Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 12/02/2026

CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE

En activité
SIREN 603 720 236

Adresse 113 RUE DE LA BRASSERIE 18200 SAINT-AMAND-MONTROND

Activité Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 21/03/1955

Dirigé par
BOUSSEDRA Redouane , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Activité

Code APE/NAF
4222Z
Libellé d'activité
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Objet
Travaux publics et particuliers installation lignes aériennes et souterraines éclairage public illuminations automatisation vidéosurveillance Irve
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 60372023600018 Siège ouvert
113 RUE DE LA BRASSERIE
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
SIRET: 60372023600075 ouvert
RUE HENRI DUNANT
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
SIRET: 60372023600117 ouvert
RTE DE MARCILLY
41300 SALBRIS
SIRET: 60372023600174 ouvert
RUE DES FOULONS
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
SIRET: 60372023600182 ouvert
ZONE INDUSTRIELLE LES NOYERS
36150 VATAN
SIRET: 60372023600216 ouvert
3 RUE Louis Bechereau PARC DE BEAULIEU ZAC ECHANGEUR
18000 Bourges
SIRET: 60372023600208 fermé
Fermé le 01/09/2019
12 RUE I ET F JOLIOT CURIE
18230 SAINT DOULCHARD
SIRET: 60372023600190 fermé
Fermé le 01/01/2018
1 AV HENRI DEBORD
18230 SAINT-DOULCHARD
SIRET: 60372023600166 fermé
Fermé le 16/02/2009
8 RUE LAVOISIER
45140 INGRE
SIRET: 60372023600141 fermé
Fermé le 15/03/2007
RUE DU PROGRES
03600 COMMENTRY
SIRET: 60372023600158 fermé
Fermé le 21/11/2005
110 RUE DES PAPILLONS GT RESEAUX CENTRE
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
SIRET: 60372023600067 fermé
Fermé le 01/01/2003
44 CHE DU PETIT PANLOUP
03400 YZEURE
SIRET: 60372023600109 fermé
Fermé le 31/12/2001
ZAC DU CHAMP DE LA BERNE
18240 LERE
SIRET: 60372023600133 fermé
Fermé le 31/12/1998

18300 BANNAY
SIRET: 60372023600059 fermé
Fermé le 01/05/1998
56 QUAI DU CANAL
42300 ROANNE
SIRET: 60372023600083 fermé
Fermé le 31/12/1996
56 RUE DE VERDUN
71170 CHAUFFAILLES
SIRET: 60372023600026 fermé
Fermé le 25/12/1996
27 RUE ROBESPIERRE
18100 VIERZON
SIRET: 60372023600125 fermé
Fermé le 25/12/1996
22 BD DU PRE PLANTIN
58000 NEVERS
SIRET: 60372023600091 fermé
Fermé le 25/12/1992
CHE DES BAS MONTOTS
58000 NEVERS

Dirigeants et représentants

2 Dirigeant(s) en exercice

BOUSSEDRA Redouane Président de SAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 672006483

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 8

FOURNITURE ET POSE DE SYSTEMES DE VIDEOPROTECTI...
Marché Services
Montant: 400 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 28/04/2026
Lieu d'exécution: 45200
Procédure: Appel d'offres ouvert
TRAVAUX ER VALENCAY
Marché Travaux
Acheteur: SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE Groupement de communes
Montant: 4 000 000,00€
Durée: 23 mois
Notification: 01/04/2026
Lieu d'exécution: 36600
Procédure: Appel d'offres ouvert
M25375R - FOURNITURE ET MAINTENANCE DES EQUIPEM...
Marché Services
Acheteur: ORLEANS METROPOLE Groupement de communes
Montant: 200 000,00€
Durée: 44 mois
Notification: 27/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
M25149S - MS065 - LOT2 - TRAVAUX D’ECLAIRAGE PU...
Marché Travaux
Acheteur: ORLEANS METROPOLE Groupement de communes
Montant: 1 269 571,81€
Durée: 9 mois
Notification: 12/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
250116M01 - FOURNITURE ET POSE DE BORNES DE REC...
Marché Fournitures
Acheteur: ORLEANS METROPOLE Groupement de communes
Montant: 94 961,70€
Durée: 2 mois
Notification: 24/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PU...
Marché Services
Montant: 210 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 02/02/2026
Lieu d'exécution: 45110
Procédure: Procédure adaptée
M25-057GRP - ACQUISITION DE MATERIELS DE VIDEOP...
Marché Fournitures
Montant: 100 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/02/2026
Lieu d'exécution: 36012
Procédure: Appel d'offres ouvert
Marché Global de Performance pour la création d...
Marché Travaux
Acheteur: CENTRE HOSPITALIER BLOIS SIMONE VEIL Établissement hospitalier
Montant: 1 455 456,00€
Durée: 72 mois
Notification: 12/01/2026
Lieu d'exécution: 41200
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
18/09/2025
N° 20250179-2133 Saint-Amand-Montrond (18204) - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/05/2025
N° 20250101-743 - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges
Avis initial
Modification de l'administration. - DELOITTE ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
BODACC B Modifications diverses
25/02/2025
N° 20250039-933 - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges
Avis initial
Modification de l'administration. - BOUSSEDRA Redouane nom d'usage : BOUSSEDRA devient président
BODACC C Dépôts des comptes
11/09/2024
N° 20240176-1085 Saint-Amand-Montrond Cedex (18204) - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/07/2023
N° 20230131-960 Saint-Amand-Montrond Cedex (18204) - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/10/2022
N° 20220197-1283 Saint-Amand-Montrond Cedex (18204) - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC B Modifications diverses
04/03/2022
N° 20220045-303 Saint-Amand-Montrond Cedex (18204) - Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : FILLASTRE Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES
BODACC C Dépôts des comptes
25/07/2021
N° 20210143-1147 Saint-Amand-Montrond Cedex (18204) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
04/08/2020
N° 20200149-1552 Saint-Amand-Montrond (18204) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
26/01/2020
N° 20200018-377 - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Modification survenue sur l'activité
BODACC B Modifications diverses
10/01/2020
N° 20200007-392 - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : COMMON Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES
BODACC B Modifications diverses
20/11/2019
N° 20190223-335 - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : COMMON Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S
BODACC C Dépôts des comptes
23/07/2019
N° 20190140-2492 Saint-Amand-Montrond (18204) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC B Modifications diverses
16/05/2019
N° 20190094-219 - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : COURTOIS Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S
BODACC B Modifications diverses
26/02/2019
N° 20190040-487 - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : SALOMON François-Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S
BODACC C Dépôts des comptes
30/08/2018
N° 20180159-2385 Saint-Amand-Montrond (18204) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
06/10/2017
N° 20170101-2734 Saint-Amand-Montrond (18204) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
10/10/2016
N° 20160108-3631 Saint-Amand-Montrond (18200) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
01/09/2015
N° 20150087-1531 Saint-Amand-Montrond (18200) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC A Ventes et cessions
02/11/2014
N° 20140211-153 Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard (18200, 18230) - Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Avis initial
Début d'activité: 2014-05-01 - Président : CROUZET Olivier Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S