Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

CHARPENTES CONTEMPORAINES

En activité
SIREN 398 183 095

Adresse

Activité Travaux de charpente

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/09/1994

Activité

Code APE/NAF
43.91A
Libellé d'activité
Travaux de charpente

Appels d'offres remportés en 2026 3

Travaux de Rénovation et requalification de la...
Marché Travaux
Montant: 2 875 211,36€
Durée: 22 mois
Notification: 20/01/2026
Lieu d'exécution: 38114
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 4 CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE ZINGUERIE LA...
Marché Fournitures
Montant: 2 875 211,36€
Durée: 22 mois
Notification: 09/01/2026
Lieu d'exécution: 38114
Procédure: Appel d'offres ouvert
AMGT MDS CAPUCINS-CHARPENTE BOIS / COUVERTURE /...
Marché Travaux
Montant: 66 637,76€
Durée: 12 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution: 73800
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
05/06/2025
N° 20250107-3824 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
Greffe du Tribunal de Commerce de grenoble
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC B Modifications diverses
31/03/2025
N° 20250064-2010 - Isère
Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble
Avis initial
Modification de l'administration. - PERRON-BAILLY Daniel Gilbert Christian nom d'usage : PERRON-BAILLY n'est plus président. Sté par actions simplifiée CEDRIC MERLET FINANCES devient président
BODACC C Dépôts des comptes
22/08/2024
N° 20240162-4177 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
Greffe du Tribunal de Commerce de grenoble
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/10/2023
N° 20230197-5374 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
Greffe du Tribunal de Commerce de grenoble
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/08/2022
N° 20220159-4647 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
Greffe du Tribunal de Commerce de grenoble
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/10/2021
N° 20210206-5064 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
03/12/2020
N° 20200235-5733 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
17/01/2020
N° 20200012-1177 - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Modification de l'administration. - PICARD Nicolas nom d'usage : PICARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SR AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
BODACC C Dépôts des comptes
07/11/2019
N° 20190215-2281 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
17/08/2018
N° 20180150-4537 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/10/2017
N° 20170105-4345 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
31/10/2016
N° 20160116-2541 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/11/2015
N° 20150124-3357 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
20/10/2014
N° 20140079-3572 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC B Modifications diverses
29/12/2013
N° 20130250-921 - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. - PERRON-BAILLY Daniel Gilbert Christian nom d'usage : PERRON-BAILLY n'est plus gérant. PERRON-BAILLY Daniel Gilbert Christian nom d'usage : PERRON-BAILLY devient président.
BODACC C Dépôts des comptes
09/09/2013
N° 20130066-5668 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC B Modifications diverses
28/08/2013
N° 20130165-845 - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Modification de l'administration. - PICARD Nicolas nom d'usage : PICARD devient commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SR AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant.
BODACC C Dépôts des comptes
30/11/2012
N° 20120086-4730 Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC B Modifications diverses
07/12/2011
N° 20110236-1562 - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Modification de l'administration. - PERRON-BAILLY Daniel Gilbert Christian nom d'usage : PERRON-BAILLY n'est plus administrateur provisoire. PERRON-BAILLY Daniel Gilbert Christian nom d'usage : PERRON-BAILLY devient gérant.
BODACC B Modifications diverses
26/10/2011
N° 20110208-1731 - Isère
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Avis initial
Modification de l'administration. - ROY Christophe nom d'usage : ROY n'est plus gérant. PERRON-BAILLY Daniel Gilbert Christian nom d'usage : PERRON-BAILLY devient administrateur provisoire.