Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 16/12/2025

COMPTOIR DE LOCATION

En activité
SIREN 431 612 175

Adresse

Activité Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/06/2000

Activité

Code APE/NAF
77.32Z
Libellé d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Appels d'offres remportés en 2026 5

Location de matériel sans chauffeur pour les se...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L ALLIER Département
Montant: 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 03000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Location de matériel sans chauffeur pour les se...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L ALLIER Département
Montant: 60 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 03000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Location de matériel sans chauffeur pour les se...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L ALLIER Département
Montant: 100 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 03000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Location de matériel sans chauffeur pour les se...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L ALLIER Département
Montant: 40 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 03000
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L AIN Département
Montant: 160 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 23/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
08/07/2025
N° 20250129-6508 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/07/2024
N° 20240146-7606 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/09/2023
N° 20230180-3214 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
02/08/2022
N° 20220148-5776 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
28/09/2021
N° 20210189-4200 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/08/2020
N° 20200159-3950 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
11/08/2020
N° 20200154-626 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : AXE TPPERARD Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Francis ; Commissaire aux comptes suppléant : ARVERNE CONSEIL
BODACC C Dépôts des comptes
06/08/2019
N° 20190150-7768 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
31/07/2018
N° 20180138-8448 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
04/08/2017
N° 20170071-9632 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/08/2016
N° 20160078-2436 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC B Modifications diverses
20/07/2016
N° 20160141-1393 - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : AXE TP (SARL) représenté par PERARD Xavier Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Francis Commissaire aux comptes suppléant : AGRET Bernard
BODACC B Modifications diverses
27/01/2016
N° 20160018-1105 - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : M.B.T.P MATERIEL BONSOIS TRAVAUX, Société par actions simplifiée (SAS), rue des Sarrazins - ZI les Fourmis 74130 Bonneville (RCS ANNECY (7401) 353 007 149)
BODACC A Ventes et cessions
11/11/2015
N° 20150217-1035 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Avis de projet de fusion AVIS DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé du 27 octobre 2015 à CLERMONT-FERRAND (63), la société COMPTOIR DE LOCATION, en abrégé CDL, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 300 000 euros, dont le siège social est Rue Rodolphe Diesel - 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°431 612 175, et la société M.B.T.P. MATERIEL BONSOIS TRAVAUX PUBLICS, en abrégé M.B.T.P., Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 105 000 euros, dont le siège social est Rue des Sarrazins, ZI Les Fourmis - 74130 BONNEVILLE, immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n°353 007 149, ont établi un projet de fusion par voie d'absorption de la société M.B.T.P. MATERIEL BONSOIS TRAVAUX PUBLICS, en abrégé M.B.T.P., par la société COMPTOIR DE LOCATION, en abrégé CDL. La société M.B.T.P. MATERIEL BONSOIS TRAVAUX PUBLICS, en abrégé M.B.T.P., ferait apport à la société COMPTOIR DE LOCATION, en abrégé CDL, de la totalité de son actif, soit 6 797 090,31 euros à charge de reprendre la totalité de son passif, soit 5 018 537,01 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 1 778 553,30 euros. Au vu du rapport d'échange établi à raison de cinq actions de la société absorbante pour une action de la société absorbée, le montant de l'augmentation de capital de la société COMPTOIR DE LOCATION, en abrégé CDL, au titre de l'absorption de la société M.B.T.P. MATERIEL BONSOIS TRAVAUX PUBLICS en abrégé M.B.T.P., serait de 450 000 euros portant le capital social à 750 000 euros, par création de 1 500 actions de 300 euros de valeur nominale. La prime de fusion s'élèverait à 1 328 553,30 euros La date de réalisation de la fusion est fixée au 31 décembre 2015 avec un effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2015. La société M.B.T.P. MATERIEL BONSOIS TRAVAUX PUBLICS se trouvera dissoute de plein droit à la date de réalisation définitive de la fusion. Cette dissolution ne sera suivie d'aucune opération de liquidation. Le projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 30/10/2015 pour la société COMPTOIR DE LOCATION, en abrégé CDL, et au Greffe du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 30/10/2015, pour la société M.B.T.P. MATERIEL BONSOIS TRAVAUX PUBLICS, en abrégé M.B.T.P.
BODACC C Dépôts des comptes
27/08/2015
N° 20150085-4878 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/08/2014
N° 20140058-5499 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/08/2013
N° 20130059-6273 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
27/07/2012
N° 20120043-8426 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC B Modifications diverses
28/09/2011
N° 20110188-1375 - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : AXE TP (SARL) représenté par PERARD Xavier Commissaire aux comptes titulaire : MASURIER Richard Commissaire aux comptes suppléant : AGRET Bernard
BODACC C Dépôts des comptes
13/09/2011
N° 20110059-7447 Clermont-Ferrand (63000) - Puy-de-Dôme
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31