Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 06/02/2025

ECOLAB SNC

En activité
SIREN 381 743 335

Adresse 10 AV ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX

Activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Forme juridique Société en nom collectif

Création 11/05/2022

Dirigé par
BUSSON SEBASTIEN JEAN GASTON , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT , ECOLAB PEST FRANCE SAS , ECOLAB SAS , GILLIG Sébastien Jean-Marie

Activité

Code APE/NAF
4675Z
Libellé d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Date de clôture d'exercice
30/11

Établissements de l'entreprise

SIRET: 38174333500220 Siège ouvert
10 AV ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX
SIRET: 38174333500212 ouvert
153 QUAI DU RANCY
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
SIRET: 38174333500238 ouvert
37 RUE Hélène Muller
94320 Thiais
SIRET: 38174333500204 fermé
Fermé le 01/07/2022
23 AV ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
SIRET: 38174333500196 fermé
Fermé le 01/07/2016
2 RUE D'YVOURS
69540 IRIGNY
SIRET: 38174333500071 fermé
Fermé le 01/11/2013
8 RUE ROUGET DE LISLE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 38174333500048 fermé
Fermé le 04/01/2010
AV DU GENERAL GEORGE SMITH PATTON Z I
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SIRET: 38174333500055 fermé
Fermé le 31/08/2009
13 AV RASPAIL 013-015
94250 GENTILLY
SIRET: 38174333500139 fermé
Fermé le 01/08/2004
2 RUE JULES VERNE ZAC DU CAILLOU
69630 CHAPONOST
SIRET: 38174333500121 fermé
Fermé le 20/08/2003
6 RUE DU GALUS VILLAGE AGORA N°6
33700 MERIGNAC
SIRET: 38174333500105 fermé
Fermé le 04/03/2003
94 RUE JEAN PERRIN ZI D'AIX
13100 AIX-EN-PROVENCE
SIRET: 38174333500188 fermé
Fermé le 04/03/2003
2 RUE DU TERTRE ZI
44470 CARQUEFOU
SIRET: 38174333500162 fermé
Fermé le 30/11/2002
RLE DU BAILLY ZI DE L'EPINETTE
59850 NIEPPE
SIRET: 38174333500113 fermé
Fermé le 31/01/2001
3 AV DES FRENES
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
SIRET: 38174333500170 fermé
Fermé le 31/03/2000
355 RUE VICTOR HUGO PARC ACTIVITES BERTEL
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
SIRET: 38174333500154 fermé
Fermé le 31/12/1999
4 IMP DE L'HERS Z.DES VIOLETTES EAST PARK
31240 L'UNION
SIRET: 38174333500097 fermé
Fermé le 25/12/1999
105 AV DE COURNON ZI VARENNE EST
63170 AUBIERE
SIRET: 38174333500147 fermé
Fermé le 30/11/1999
9 IMP SAINT LIVIER
54130 SAINT-MAX
SIRET: 38174333500089 fermé
Fermé le 16/07/1998
ZI KENEACH LERIAN SUD
56400 PLOUGOUMELEN
SIRET: 38174333500014 fermé
Fermé le 25/12/1993
4 RUE DE L'ABREUVOIR CENTRE D'AFFAIRES LA DEFEN
92400 COURBEVOIE
SIRET: 38174333500030 fermé
Fermé le 25/12/1993
150 RUE GALLIENI
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
SIRET: 38174333500063 fermé
Fermé le 01/01/1993
118 AV JEAN JAURES
75019 PARIS

Dirigeants et représentants

5 Dirigeant(s) en exercice

BUSSON SEBASTIEN JEAN GASTON Gérant
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 672006483
ECOLAB PEST FRANCE SAS Autre
 SIREN: 341039105
ECOLAB SAS Autre
 SIREN: 622035277
GILLIG Sébastien Jean-Marie Gérant

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 6

FOURNITURE D?ARTICLES POUR LE GROUPEMENT DE COM...
Marché Fournitures
Acheteur: CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE Établissement hospitalier
Montant: 40 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 28/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Uniha _M_3049 MARCHE SUBSEQUENT N°2 FOURNITURE...
Marché Fournitures
Acheteur: CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU Établissement hospitalier
Montant: 260 603,00€
Durée: 39 mois
Notification: 15/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Marché subséquent N°1 - FOURNITURE DE PRODUITS...
Marché Fournitures
Acheteur: CTRE HOSPITALIER UNIVERS PONTCHAILLOU Établissement hospitalier
Montant: 88 917,00€
Durée: 39 mois
Notification: 15/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE PRODUITS LESSIVIELS
Marché Fournitures
Acheteur: CHU NANTES (DIRECTION GENERALE) Établissement hospitalier
Montant: 704 000,00€
Durée: 42 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
BIHLSUD 2025-02 FOURNITURE DE PRODUITS LESSIVIE...
Marché Fournitures
Acheteur: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Établissement hospitalier
Montant: 282 027,00€
Durée: 48 mois
Notification: 06/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Uniha _M_3049 Produits lessiviels AC 2025-2029...
Marché Fournitures
Montant: 21,59€
Durée: 42 mois
Notification: 20/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
27/05/2025
N° 20250101-6013 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-11-30
BODACC B Modifications diverses
07/02/2025
N° 20250027-10138 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : BUSSON Sébastien, Jean, Gaston ; Gérant : GILLIG Sébastien, Jean-Marie ; Associé en nom : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
BODACC B Modifications diverses
11/08/2024
N° 20240155-3746 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : TOURNIER Benoît, Charles, Michel ; Gérant : BUSSON Sébastien, Jean, Gaston ; Associé en nom : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
BODACC C Dépôts des comptes
21/06/2024
N° 20240119-4551 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-11-30
BODACC B Modifications diverses
08/08/2023
N° 20230151-2684 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : DURAND Vincent, Pierre, André ; Gérant : TOURNIER Benoît, Charles, Michel ; Associé en nom : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
BODACC C Dépôts des comptes
13/06/2023
N° 20230112-8761 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-11-30
BODACC B Modifications diverses
13/07/2022
N° 20220135-1962 Bagneux (92220) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration, la date de début d'activité, transfert du siège social. - Gérant : DUMORTIER Virginie ; Gérant : DURAND Vincent, Pierre, André ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Associé en nom : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Associé en nom : ECOLAB SAS
BODACC C Dépôts des comptes
14/06/2022
N° 20220114-5394 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-11-30
BODACC B Modifications diverses
22/02/2022
N° 20220037-2848 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Avis initial
Modification survenue sur le capital.
BODACC A Ventes et cessions
17/02/2022
N° 20220034-2014 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION ECOLAB SNC Société en nom collectif Au capital de : 41 175 000,00 EUR Siège social 23 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil N° RCS 381 743 335 RCS Créteil, est société absorbante BIOQUELL HOLDING Société par actions simplifiée Au capital de : 2 085 000,00 EUR Siège social 153 Quai du Rancy 94380 Bonneuil-sur-Marne N° RCS 517 880 480 RCS Créteil, est société absorbée Actif : 2 162 925,00 EUR Passif : 162 600,00 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : Compte tenu de la détention par la société absorbante de la totalité des titres composant le capital social de la société absorbée, il ne sera procédé à aucune émission d’actions nouvelles de la société absorbante, ni à une augmentation de son capital en contrepartie de l’apport réalisé par la société absorbée. En conséquence, il n’y a pas lieu de déterminer un rapport d’échange. La différence entre la valeur de l’actif net reçu par la société absorbante, soit 2 000 325 EUR, et la valeur nette comptable des titres de la société absorbée dans les écritures de la société absorbante, soit 7 137 398,37 EUR, est constitutive d’un mali de fusion d’un montant de 5 137 073,37 EUR. Montant prévu de la prime de fusion : néant Date du projet : 15/02/2022 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 15/02/2022, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Créteil au nom de la société BIOQUELL HOLDING et au nom de la société ECOLAB SNC
BODACC B Modifications diverses
19/10/2021
N° 20210204-4035 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : DUMORTIER Virginie ; Gérant : DURAND Vincent, Pierre, André ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Associé : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
BODACC B Modifications diverses
16/07/2021
N° 20210137-5397 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : MARTIN David ; Gérant : DUMORTIER Virginie ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Associé : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
BODACC B Modifications diverses
11/07/2021
N° 20210134-2242 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : MARTIN David ; Gérant : DUMORTIER Virginie ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Associé : ECOLAB PEST FRANCE SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
BODACC C Dépôts des comptes
30/06/2021
N° 20210126-5838 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-11-30
BODACC C Dépôts des comptes
15/07/2020
N° 20200135-10286 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-11-30
BODACC B Modifications diverses
18/07/2019
N° 20190137-5207 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Gérant : MARTIN David ; Gérant : MELEUX Virginie ; Associé en nom : ECOLAB SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
BODACC C Dépôts des comptes
16/07/2019
N° 20190135-11910 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-11-30
BODACC B Modifications diverses
24/03/2019
N° 20190059-3438 - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification de représentant. - Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 19 Décembre 2013 ; Associé en nom : ECOLAB SAS en fonction le 19 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 15 Juillet 2015 ; Gérant : MARTIN David en fonction le 21 Mars 2019
BODACC C Dépôts des comptes
24/07/2018
N° 20180133-13430 Arcueil (94110) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-11-30
BODACC B Modifications diverses
18/07/2018
N° 20180134-3540 - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification de représentant. - Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 19 Décembre 2013 ; Associé en nom : ECOLAB SAS en fonction le 19 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 15 Juillet 2015 ; Gérant : LAROCHE Bertrand en fonction le 15 Janvier 2016