Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 12/09/2024

EUROVIA STR

En activité
SIREN 310 624 523

Adresse RUE ARMAND CARREL ZI DE PETITE SYNTHE 59640 DUNKERQUE

Activité Construction de routes et autoroutes

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 02/07/1981

Dirigé par
BOUARFA LAHBIB , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Activité

Code APE/NAF
4211Z
Libellé d'activité
Construction de routes et autoroutes
Objet
Travaux publics - Etude et réalisation de tous travaux publics et particuliers, transports publics ou privés, travaux de restauration rénovation, nettoiement. Transports routiers : services des transports de marchandises pour le compte d'autrui. Transports routiers, location de véhicules pour le transport routier de marchandises, commissionnaire de transport.
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 31062452300117 Siège ouvert
RUE ARMAND CARREL ZI DE PETITE SYNTHE
59640 DUNKERQUE
SIRET: 31062452300141 ouvert
84 RTE NATIONALE HAM D'ENNETIERES
59710 AVELIN
SIRET: 31062452300307 fermé
Fermé le 01/01/2005
RUE EVRARD PERE
62330 ISBERGUES
SIRET: 31062452300315 fermé
Fermé le 01/01/2005
720 RUE LOUIS BREGUET ZAC MARCEL DORET
62100 CALAIS
SIRET: 31062452300174 fermé
Fermé le 31/12/2002
BD INDUSTRIEL RESURGAT III LOT N6
62230 OUTREAU
SIRET: 31062452300281 fermé
Fermé le 31/12/2002
RUE DES MOUETTES ZI DES DUNES
62100 CALAIS
SIRET: 31062452300224 fermé
Fermé le 14/07/2002
AV JEAN WATEL
62000 DAINVILLE
SIRET: 31062452300232 fermé
Fermé le 14/07/2002
RUE JEAN JAURES
62217 BEAURAINS
SIRET: 31062452300257 fermé
Fermé le 14/07/2002
PL JEAN JAURES CHANTIER
62217 ACHICOURT
SIRET: 31062452300265 fermé
Fermé le 14/07/2002

62217 AGNY
SIRET: 31062452300299 fermé
Fermé le 01/01/2002
18 RUE ALFRED DE VIGNY
59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
SIRET: 31062452300133 fermé
Fermé le 31/12/2001
7 ZAL DU CHAMPS DU CLERC
62160 AIX-NOULETTE
SIRET: 31062452300158 fermé
Fermé le 31/12/2001
105 RUE LOUIS BREGUET ZAC MARCEL DORET
62100 CALAIS
SIRET: 31062452300166 fermé
Fermé le 31/12/2001
17 RUE SAINT-JACQUES
59300 VALENCIENNES
SIRET: 31062452300240 fermé
Fermé le 31/12/2001
RUE DU BOIS
59930 LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES
SIRET: 31062452300273 fermé
Fermé le 31/12/2001
LES GRANDS PRES PARC ENTREPRISE
62950 NOYELLES GODAULT
SIRET: 31062452300091 fermé
Fermé le 31/12/2000
CHE chemin de la Warenne
62224 EQUIHEN-PLAGE
SIRET: 31062452300190 fermé
Fermé le 25/12/1997
PL HENRI CADOT CHANTIER
62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
SIRET: 31062452300208 fermé
Fermé le 25/12/1997
AV ARTHUR LAMENDIN CHANTIER
62800 LIEVIN
SIRET: 31062452300216 fermé
Fermé le 25/12/1997
9000 BD VOLTAIRE CHANTIER
62200 BOULOGNE-SUR-MER
SIRET: 31062452300125 fermé
Fermé le 25/12/1996
20 RUE DE LILLE
59710 AVELIN
SIRET: 31062452300182 fermé
Fermé le 25/12/1996
HERQUELINGUE CHANTIER
62360 ISQUES
SIRET: 31062452300075 fermé
Fermé le 25/12/1994
RUE CARNOT
62370 AUDRUICQ
SIRET: 31062452300083 fermé
Fermé le 25/12/1993
70 RUE MOLLIEN
62100 CALAIS

Dirigeants et représentants

2 Dirigeant(s) en exercice

BOUARFA LAHBIB Président de SAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 672006483

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 10

DV-ARDK PROG ENTRETIEN 2026 BEBI RD 642 ENTRE...
Marché Travaux
Acheteur: DEPARTEMENT DU NORD Département
Montant: 168 674,04€
Durée: 12 mois
Notification: 02/04/2026
Lieu d'exécution: 59173
Procédure: Procédure adaptée
DV DK ENTRETIEN DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE OPER...
Marché Travaux
Acheteur: DEPARTEMENT DU NORD Département
Montant: 104 155,30€
Durée: 12 mois
Notification: 23/03/2026
Lieu d'exécution: 59140
Procédure: Procédure adaptée
DV DK 2026 ENTRETRIENT ROUTES DEPARTEMENTALES
Marché Travaux
Acheteur: DEPARTEMENT DU NORD Département
Montant: 750 000,00€
Durée: 18 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution: 59140
Procédure: Procédure adaptée
RECONSTRUCTION SERVICES TECHNIQUES LOT1 VRD AME...
Marché Travaux
Montant: 225 857,50€
Durée: 12 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Travaux de VRD_Requalification du Parc d’Activi...
Marché Travaux
Acheteur: CC PEVELE-CAREMBAULT Groupement de communes
Montant: 2 300 000,00€
Durée: 32 mois
Notification: 03/03/2026
Lieu d'exécution: 59710
Procédure: Procédure adaptée
REFECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS RUES PAUL M...
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE Groupement de communes
Montant: 1 182 443,90€
Durée: 24 mois
Notification: 12/02/2026
Lieu d'exécution: 59140
Procédure: Appel d'offres ouvert
DV ARDK OPERATION 24PCS-DK047E-RBB RENOUVELLEME...
Marché Travaux
Acheteur: DEPARTEMENT DU NORD Département
Montant: 71 417,30€
Durée: 12 mois
Notification: 27/01/2026
Lieu d'exécution: 59630
Procédure: Procédure adaptée
DV ARDK RENOUVELLEMENT COUCHE SURFACE OPE 25SPC...
Marché Travaux
Acheteur: DEPARTEMENT DU NORD Département
Montant: 88 510,50€
Durée: 12 mois
Notification: 27/01/2026
Lieu d'exécution: 59143
Procédure: Procédure adaptée
VOIRIE - ACCORD-CADRE - ÉXÉCUTION DE TRAVAUX
Marché Travaux
Montant: 1 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution: 59820
Procédure: Procédure adaptée
VOIRIE - ACCORD-CADRE - ÉXÉCUTION DE TRAVAUX
Marché Travaux
Montant: 1 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
31/07/2025
N° 20250145-7864 Petite Synthe (59640) - Nord
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/07/2024
N° 20240139-5642 Petite Synthe (59640) - Nord
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/09/2023
N° 20230175-15185 Petite Synthe (59640) - Nord
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/06/2022
N° 20220126-8709 Petite Synthe (59640) - Nord
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC B Modifications diverses
10/02/2022
N° 20220029-1104 - Nord
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Avis initial
Modification de l'administration. - RUCQUOY Claude Michel nom d'usage : RUCQUOY n'est plus directeur technique
BODACC C Dépôts des comptes
26/08/2021
N° 20210166-5448 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC B Modifications diverses
15/11/2020
N° 20200222-310 - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Modification de l'administration. - SA KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT ID n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
BODACC C Dépôts des comptes
11/10/2020
N° 20200198-5315 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
24/10/2019
N° 20190206-5949 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/08/2018
N° 20180154-3724 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/08/2017
N° 20170083-4025 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
16/08/2016
N° 20160082-6097 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/06/2015
N° 20150055-3792 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
05/07/2014
N° 20140037-6288 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC B Modifications diverses
18/12/2013
N° 20130243-1240 - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : BOUARFA LAHBIB Directeur technique : RUCQUOY Claude, Michel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SA) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
BODACC C Dépôts des comptes
23/07/2013
N° 20130040-5305 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
01/08/2012
N° 20120046-9075 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC B Modifications diverses
12/04/2012
N° 20120072-2660 - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : BOUARFA LAHBIB Directeur des transports : RUCQUOY Claude, Michel Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SARL)
BODACC C Dépôts des comptes
29/08/2011
N° 20110050-7082 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/09/2010
N° 20100058-6855 Petite Synthe (59640) - Nord
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31