Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

FRANFINANCE LOCATION

En activité
SIREN 314 975 806

Adresse

Activité Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/01/1979

Activité

Code APE/NAF
77.33Z
Libellé d'activité
Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique

Appels d'offres remportés en 2026 4

Location et maintenance des photocopieurs
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNE DE CENON (MAIRIE) Commune
Montant: 300 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 28/04/2026
Lieu d'exécution: 33150
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture et prestations pour Vidéochirurgie,...
Marché Fournitures
Montant: 317 511,00€
Durée: 132 mois
Notification: 10/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
2022032LOT4 PRESSE IMPRIMERIE RESAH MARCHE SUBS...
Marché Fournitures
Montant: 225 000,00€
Durée: 60 mois
Notification: 01/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
SERVICES D’INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - POSTES...
Marché Fournitures
Montant: 200 000,00€
Durée: 54 mois
Notification: 04/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC A Ventes et cessions
06/03/2026
N° 20260045-1884 Paris 13e Arrondissement, Puteaux (75013, 92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Acte en date du 19/12/2025 enregistré au Nanterre le 15/01/2026 sous le numéro 2026 00002474 9214P03 2026A00115 Adresse de l'ancien propriétaire: 17 Cours Valmy Tour Granite Cs 50318 92800 Puteaux
BODACC C Dépôts des comptes
30/07/2025
N° 20250144-8611 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC A Ventes et cessions
20/05/2025
N° 20250096-4458 Paris 13e Arrondissement, Puteaux (75013, 92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Acte en date du 30/04/2025 enregistré au SPFE de Nanterre le 14/05/2025 sous le numéro Dossier : 2025 00025724 Références : 9214P03 2025 A 02040 Adresse de l'ancien propriétaire: 17 Cours Valmy Tour Granite Cs 50318 92800 Puteaux - Début d'activité: 2025-04-30
BODACC B Modifications diverses
07/02/2025
N° 20250027-10142 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
BODACC C Dépôts des comptes
23/07/2024
N° 20240141-11277 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC B Modifications diverses
18/07/2024
N° 20240138-5472 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : DELAPORTE Olivier ; Directeur général : JACOB-PERON Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
BODACC B Modifications diverses
20/06/2024
N° 20240118-4653 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : DELAPORTE Olivier ; Directeur général : JACOB-PERON Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
BODACC C Dépôts des comptes
13/07/2023
N° 20230134-11785 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
01/07/2022
N° 20220127-4635 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/01/2022
N° 20220019-5055 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : DELAPORTE Olivier ; Directeur général : JACOB-PERON Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
BODACC C Dépôts des comptes
29/07/2021
N° 20210146-14060 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC B Modifications diverses
19/05/2021
N° 20210097-2862 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : DELAPORTE Olivier ; Directeur général : JACOB-PERON Frédéric ; Directeur général délégué : BAUGE Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
BODACC C Dépôts des comptes
02/08/2020
N° 20200148-5723 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/07/2019
N° 20190140-14007 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC B Modifications diverses
11/07/2019
N° 20190132-2541 Nanterre Cedex (92724) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de l'adresse du siège.
BODACC C Dépôts des comptes
11/07/2018
N° 20180125-17308 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC B Modifications diverses
11/03/2018
N° 20180049-1467 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant. - Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 23 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 23 Septembre 2013 ; Directeur général délégué : BAUGE Alain en fonction le 30 Mai 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES modification le 23 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 23 Septembre 2013 ; Président : OCHONISKY Julien modification le 12 Janvier 2018 ; Directeur général : JACOB-PERON Frédéric en fonction le 26 Décembre 2017
BODACC B Modifications diverses
29/12/2017
N° 20170250-2530 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant.. - Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 23 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 23 Septembre 2013 ; Directeur général délégué : BAUGE Alain en fonction le 30 Mai 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES modification le 23 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS modification le 23 Septembre 2013 ; Directeur général : TOUATI Gérard modification le 06 Février 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : OCHONISKY Julien en fonction le 06 Février 2015 ; Directeur général : JACOB-PERON Frédéric en fonction le 26 Décembre 2017
BODACC C Dépôts des comptes
15/07/2017
N° 20170062-11140 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/07/2016
N° 20160070-8032 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31