Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 06/07/2024

G GILLARD SAS

En activité
SIREN 906 850 268

Adresse RUE DES PEUPLIERS ZA 77590 BOIS-LE-ROI

Activité Fabrication de carrosseries et remorques

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 23/07/1968

Dirigé par
GILLARD BRUNO , BONTEMPS PHILIPPE , GILLARD BRUNO , AUDIT PLUS

Activité

Code APE/NAF
2920Z
Libellé d'activité
Fabrication de carrosseries et remorques
Objet
Construction metallique serrurerie ferronnerie installation de bruleur à mazout - tous travaux de mecanique, de reparation, d'entretien, d'equipement, de carrosserie et de tolerie pour tous vehicules, engins mobiles et materiel roulant ainsi qu'a l'achat la vente l'importation l'exportation et le commissionnement de tous vehicules legers, utilitaires, poids lourds et engins mobiles et materiels roulants et d'une maniere generale de tout ce qui peut se rapporter directement ou indirectement à l'activite de garage en general, vente de pieces detachees et accessoires etc. Ainsi que l'enlevement d'ordures menageres ou autres - la creation la fabrication de compacteurs à dechets ainsi que toutes autres realisations dans la gestion le transport de dechets industriels et menagers.
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 90685026800028 Siège ouvert
RUE DES PEUPLIERS ZA
77590 BOIS-LE-ROI
SIRET: 90685026800044 ouvert
RUE DE BRETAGNE ZI ETIC PORTE D
77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
SIRET: 90685026800051 ouvert
RUE DE L'AQUEDUC
77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE
SIRET: 90685026800036 fermé
Fermé le 25/12/1995
47 RUE DE L'AQUEDUC
77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Dirigeants et représentants

4 Dirigeant(s) en exercice

GILLARD BRUNO Président de SAS
BONTEMPS PHILIPPE Commissaire aux comptes suppléant
GILLARD BRUNO Président de SAS
AUDIT PLUS Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 397754748

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 11

FOURNITURE 2 CAISSONS COMPACTEURS EMBARQUES POU...
Marché Fournitures
Acheteur: CC DU SISTERONAIS-BUECH (ORDURES MENAGERES) Groupement de communes
Montant: 67 640,64€
Durée: 1 mois
Notification: 20/03/2026
Lieu d'exécution: 04200
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURES MATERIELS SPECIFIQUES A LA GESTION...
Marché Fournitures
Montant: 1 200 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution: 63200
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURES MATERIELS SPECIFIQUES A LA GESTION...
Marché Fournitures
Montant: 1 000 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution: 63200
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture et livraison de bennes et containers
Marché Fournitures
Acheteur: SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT Syndicat mixte
Montant: 181 250,00€
Durée: 36 mois
Notification: 09/03/2026
Lieu d'exécution: 50620
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 2 : Fourniture, installation et maintenance...
Marché Services
Acheteur: GRAND PARIS SUD EST AVENIR Groupement de communes
Montant: 100 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 06/03/2026
Lieu d'exécution: 94046
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de composteurs en plastique
Marché Fournitures
Acheteur: LE MURETAIN AGGLO Groupement de communes
Montant: 1 200 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 31601
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURES DE BENNES FILTRANTES
Marché Fournitures
Acheteur: CC DU SARTENAIS VALINCO TARAVO Groupement de communes
Montant: 60 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 28/02/2026
Lieu d'exécution: 20110
Procédure: Procédure adaptée
FOURNITURES DE BENNES TRANSPORT
Marché Fournitures
Acheteur: CC DU SARTENAIS VALINCO TARAVO Groupement de communes
Montant: 69 120,00€
Durée: 48 mois
Notification: 28/02/2026
Lieu d'exécution: 20110
Procédure: Procédure adaptée
L1 BENNES AMOVIBLES
Marché Fournitures
Acheteur: SYNDICAT MIXTE DECOSET Syndicat mixte
Montant: 1 800 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/02/2026
Lieu d'exécution: 31130
Procédure: Appel d'offres ouvert
COMPACTEURS MONOBLOCS ET SYSTEMES DE CHARGEMENT...
Marché Fournitures
Acheteur: TRINOVAL EPIC
Montant: 397 900,03€
Durée: 6 mois
Notification: 28/01/2026
Lieu d'exécution: 80640
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de caisses pour les déchèteries
Marché Fournitures
Acheteur: SICTOM DU MARSAN Syndicat mixte
Montant: 200 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 16/01/2026
Lieu d'exécution: 40090
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
17/09/2025
N° 20250178-3815 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
31/07/2024
N° 20240147-1260 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
15/08/2023
N° 20230156-6915 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/07/2022
N° 20220141-8989 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/08/2021
N° 20210168-3026 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/10/2020
N° 20200197-4930 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/10/2019
N° 20190204-5773 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
08/08/2018
N° 20180144-9895 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
08/09/2017
N° 20170091-11020 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/07/2016
N° 20160074-6338 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC A Ventes et cessions
24/06/2016
N° 20160124-1104 Champagne-sur-Seine, Bois-le-Roi (77430, 77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
- Achat d'une branche d'activité de fabrication et vente d'abris mobiles déployables précédemment exploité par la société GILLARD ZA Rue des Peupliers 77590 BOIS LE ROI au prix stipulé de 200 000 euros. Acte du 31/12/2015 enregistré au SIE de Melun Extérieur le 17/06/2016. Bordereau 2016/1057 Case 2. Oppositions dans les 10 jours de la présente insertion. Domicile du vendeur : ZA Rue des Peupliers 77590 BOIS LE ROI. - Début d'activité: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
06/08/2015
N° 20150073-6035 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
01/09/2014
N° 20140062-6487 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC B Modifications diverses
24/08/2014
N° 20140161-3108 - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Modification de représentant. - Président : GILLARD BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT PLUS modification le 14 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BONTEMPS Philippe en fonction le 14 Août 2014
BODACC C Dépôts des comptes
09/09/2013
N° 20130066-10206 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/08/2012
N° 20120051-6115 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC B Modifications diverses
17/07/2012
N° 20120136-1886 - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Modification du capital.
BODACC C Dépôts des comptes
23/09/2011
N° 20110064-10902 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31
BODACC B Modifications diverses
07/09/2011
N° 20110173-2485 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Changement de commissaire aux comptes - Président de la société : GILLARD BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : SZAMES HELENE Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT PLUS
BODACC C Dépôts des comptes
15/09/2010
N° 20100062-11342 Bois-le-Roi (77590) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31