Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

GROUPE ATELIERS DE VILLETANEUSE

En activité
SIREN 300 846 292

Adresse

Activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/01/1974

Activité

Code APE/NAF
46.66Z
Libellé d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Appels d'offres remportés en 2026 10

POUR 4 LYCÉES NORMANDS - ACQUISITION DE 6 EQUIP...
Marché Fournitures
Montant: 84 929,99€
Durée: 12 mois
Notification: 16/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
POUR 4 LYCÉES NORMANDS - ACQUISITION DE 6 MAQUE...
Marché Fournitures
Montant: 76 769,16€
Durée: 12 mois
Notification: 13/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
POUR 4 LYCÉES NORMANDS - ACQUISITION DE 6 MAQUE...
Marché Fournitures
Montant: 76 769,16€
Durée: 12 mois
Notification: 13/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Le présent marché public a pour objet la fourni...
Marché Fournitures
Montant: 11 073,15€
Durée: 12 mois
Notification: 07/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Le présent marché public a pour objet la fourni...
Marché Fournitures
Montant: 16 744,11€
Durée: 12 mois
Notification: 07/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Fourniture installation mise en service d’équip...
Marché Fournitures
Acheteur: COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE Département outre-mer
Montant: 129 601,57€
Durée: 3 mois
Notification: 03/03/2026
Lieu d'exécution: 97320
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture installation, mise en oeuvre d’équip...
Marché Fournitures
Acheteur: COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE Département outre-mer
Montant: 116 498,26€
Durée: 2 mois
Notification: 03/03/2026
Lieu d'exécution: 97320
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Fourniture installation, mise en oeuvre d’équip...
Marché Fournitures
Acheteur: COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE Département outre-mer
Montant: 447 492,96€
Durée: 5 mois
Notification: 03/03/2026
Lieu d'exécution: 97320
Procédure: Appel d'offres ouvert
Equipements pédagogiques à vocation industriell...
Marché Fournitures
Montant: 1 400 000,00€
Durée: 12 mois
Notification: 04/02/2026
Lieu d'exécution: 14000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Equipements pédagogiques à vocation industriell...
Marché Fournitures
Montant: 2 000 000,00€
Durée: 12 mois
Notification: 04/02/2026
Lieu d'exécution: 14000
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 12

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
05/11/2019
N° 20190213-10889 Groslay (95410) - Yvelines
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
15/01/2019
N° 20190010-4658 Groslay (95410) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
04/04/2018
N° 20180061-8113 Groslay (95410) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-03-31
BODACC B Modifications diverses
17/08/2016
N° 20160160-1682 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification de représentant.. - Directeur général : JACQUES-DELIZEE Michel Francois modification le 11 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : CHOMBART Jean Louis en fonction le 16 Janvier 1997 Président : JACQUES Bertrand modification le 11 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : TCHAMGOUE SAHA Elie Clotaire en fonction le 24 Décembre 2015
BODACC B Modifications diverses
05/01/2016
N° 20160002-2764 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification de représentant.. - Président : JACQUES-DELIZEE Michel Francois modification le 16 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CHOMBART Jean Louis en fonction le 16 Janvier 1997 Directeur général : JACQUES Bertrand modification le 24 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : TCHAMGOUE SAHA Elie Clotaire en fonction le 24 Décembre 2015
BODACC B Modifications diverses
04/02/2014
N° 20140024-1927 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification du nom commercial.
BODACC B Modifications diverses
13/06/2013
N° 20130112-3107 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification du nom commercial.
BODACC B Modifications diverses
26/08/2011
N° 20110165-2383 Groslay (95410) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification de l'adresse du siège. Modification du sigle.
BODACC B Modifications diverses
26/03/2010
N° 20100060-3963 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification de la forme juridique. Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification de représentant. - Président : JACQUES-DELIZEE Michel Francois modification le 16 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CHOMBART Jean Louis en fonction le 16 Janvier 1997 Commissaire aux comptes suppléant : VOISINE Christian en fonction le 22 Janvier 2005
BODACC C Dépôts des comptes
22/12/2009
N° 20090098-11161 Baillet-en-France (95560) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
05/01/2009
N° 20090001-11516 Baillet-en-France (95560) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2008-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/01/2008
N° 20080001-10843 Baillet-en-France (95560) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2007-03-31