Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 04/12/2025

GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES

En activité
SIREN 341 922 680

Adresse BD DES CHAMPS MAROTS ZI ST MEDARD DES PRES 85200 FONTENAY-LE-COMTE

Activité Travaux de montage de structures métalliques

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 06/08/1987

Dirigé par
CARMYN , PACEMETAL , AMIQUAR

Activité

Code APE/NAF
4399B
Libellé d'activité
Travaux de montage de structures métalliques
Objet
serrurerie ferronnerie chaudronnerie et construc- tions metalliques
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 34192268000028 Siège ouvert
BD DES CHAMPS MAROTS ZI ST MEDARD DES PRES
85200 FONTENAY-LE-COMTE
SIRET: 34192268000044 fermé
Fermé le 31/03/2004
6 IMP DES VIGNES VIERGES
85200 AUCHAY-SUR-VENDEE
SIRET: 34192268000036 fermé
Fermé le 25/12/1992
1 RUE DU FOUILLOUX
85200 FONTENAY-LE-COMTE

Dirigeants et représentants

3 Dirigeant(s) en exercice

CARMYN Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 789954161
PACEMETAL Président de SAS
 SIREN: 400575569
AMIQUAR Administrateur
 SIREN: 382648723

Comptes annuels 8

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 10

Construction de 4 logements rue Turgot et 3 log...
Marché Travaux
Montant: 4 554,00€
Durée: 40 mois
Notification: 31/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Construction de 4 logements rue Turgot et 3 log...
Marché Travaux
Montant: 11 022,00€
Durée: 40 mois
Notification: 31/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
CONSTRUCTION D’UNE CRECHE - LOT 5
Marché Travaux
Montant: 102 645,00€
Durée: 12 mois
Notification: 24/03/2026
Lieu d'exécution: 85530
Procédure: Procédure adaptée
CHARPENTE/COUVERTURE ET BARDAGE METTALIQUE - ME...
Marché Travaux
Montant: 90 791,00€
Durée: 9 mois
Notification: 20/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
LOT2-REHABILITATION SITE EXPLOITATION DES BENNE...
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LA ROCHELLE Groupement de communes
Montant: 177 226,00€
Durée: 1 mois
Notification: 20/03/2026
Lieu d'exécution: 17000
Procédure: Procédure adaptée
Construction de 13 logements, avenue Georges Po...
Marché Travaux
Montant: 58 585,00€
Durée: 34 mois
Notification: 18/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 5 - Bardage métallique
Marché Travaux
Montant: 89 728,24€
Durée: 13 mois
Notification: 16/03/2026
Lieu d'exécution: 85120
Procédure: Procédure adaptée
Lot 5 - Couverture et bardage metallique - Port...
Marché Travaux
Montant: 190 000,00€
Durée: 12 mois
Notification: 20/02/2026
Lieu d'exécution: 85120
Procédure: Procédure adaptée
Lot 4 - Charpente metallique serrurerie
Marché Travaux
Montant: 209 846,00€
Durée: 12 mois
Notification: 30/01/2026
Lieu d'exécution: 85120
Procédure: Procédure adaptée
HDVA - LOT N° 8 SERRURERIE
Marché Travaux
Montant: 750 057,00€
Durée: 51 mois
Notification: 22/01/2026
Lieu d'exécution: 85000
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
13/01/2026
N° 20260007-2276 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2025-07-31
BODACC B Modifications diverses
11/12/2025
N° 20250238-3196 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Président partant : SB2G représenté par 26 R SAVARY DE MAULEON 85200 Fontenay-le-Comte ; nomination du Président : PACEMETAL ; nomination de l'Administrateur : AMIQUAR
BODACC C Dépôts des comptes
06/06/2025
N° 20250108-4873 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-07-31
BODACC B Modifications diverses
02/06/2025
N° 20250105-6716 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Commissaire aux comptes titulaire partant : BESSIERES EXPERTISE ; nomination du Commissaire aux comptes : CARMYN
BODACC C Dépôts des comptes
25/04/2024
N° 20240082-5392 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
28/04/2023
N° 20230084-2423 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/03/2022
N° 20220051-7854 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
24/02/2021
N° 20210038-3965 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-07-31
BODACC B Modifications diverses
21/02/2021
N° 20210036-2309 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Commissaire aux comptes titulaire partant : Lansiaux, Olivia ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BESSIERES EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SYMBIOSE AUDIT
BODACC C Dépôts des comptes
09/02/2020
N° 20200028-2278 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/06/2019
N° 20190115-10887 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/02/2019
N° 20190032-4637 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/02/2017
N° 20170015-9310 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
03/03/2016
N° 20160025-8267 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
28/03/2015
N° 20150026-7539 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/03/2014
N° 20140016-10329 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/03/2013
N° 20130017-9587 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-07-31
BODACC B Modifications diverses
21/06/2012
N° 20120118-1709 - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de représentant. - Administrateur : GUYONNET Michel André Valentin Administrateur : GUYONNET Jean-Yves Administrateur : SB2G représenté par CHESSE Claude Commissaire aux comptes titulaire : LANSIAUX Olivia Commissaire aux comptes suppléant : SYMBIOSE AUDIT Président : SB2G représenté par GUILBAUDEAU Jean-Yves en fonction le 13 Juin 2012
BODACC C Dépôts des comptes
26/03/2012
N° 20120018-8806 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-07-31
BODACC C Dépôts des comptes
16/05/2011
N° 20110026-10987 Fontenay-le-Comte (85200) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-07-31