Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

NEDAP FRANCE

En activité
SIREN 411 513 237

Adresse

Activité Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 05/03/1997

Activité

Code APE/NAF
43.21A
Libellé d'activité
Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Appels d'offres remportés en 2026 13

Le présent marché concerne les prestations de m...
Marché Services
Montant: 67 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 26/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
FOURNITURE DE SOLUTIONS RFID - LOT 1 DEPLOIEMEN...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS Groupement de communes
Montant: 730 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution: 59253
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE SOLUTIONS RFID - LOT 2 FOURNITURE...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS Groupement de communes
Montant: 56 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution: 59253
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de solutions RFID pour le réseau de...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS Groupement de communes
Montant: 730 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de solutions RFID pour le réseau de...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS Groupement de communes
Montant: 56 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RFID DE...
Marché Services
Montant: 173 140,00€
Durée: 48 mois
Notification: 18/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
MS0 - FOURNITURE MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNE DE METZ (MAIRIE) Commune
Montant: 214 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 13/03/2026
Lieu d'exécution: 57036
Procédure: Procédure adaptée
Fourniture, installation et maintenance d’un sy...
Marché Fournitures
Montant: 120 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 63500
Procédure: Procédure adaptée
Fourniture, installation et maintenance d’un sy...
Marché Fournitures
Montant: 120 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 63500
Procédure: Procédure adaptée
CONTRAT MAINTENANCE INSTALLATION CONTROLE ACCES
Marché Services
Montant: 91 980,00€
Durée: 60 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 93700
Procédure: Procédure adaptée
FOURNITURE, MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE D’UNE...
Marché Fournitures
Acheteur: CA QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE Groupement de communes
Montant: 450 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 09/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
MAINTENANCE ET TELEASSISTANCE DU SYSTEME RFID P...
Marché Services
Montant: 59 340,00€
Durée: 47 mois
Notification: 23/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
MAINTENANCE ET TELEASSISTANCE DES LOGICIELS ET...
Marché Services
Montant: 150 486,00€
Durée: 48 mois
Notification: 20/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC B Modifications diverses
20/01/2026
N° 20260012-10209 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SOLUTYS CORPORATE ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUREALYS
BODACC C Dépôts des comptes
06/08/2025
N° 20250149-11758 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/08/2024
N° 20240161-7445 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/09/2023
N° 20230175-22494 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/11/2022
N° 20220229-4455 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/10/2021
N° 20210201-11466 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
28/08/2020
N° 20200167-3589 Éragny Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
26/11/2019
N° 20190227-3412 Éragny Cedex (95611) - Yvelines
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : NV Partner Invest ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUREALYS
BODACC C Dépôts des comptes
09/07/2019
N° 20190130-14207 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC B Modifications diverses
13/09/2018
N° 20180174-2313 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification de représentant. - Président : PAIJENS Cornelis Johannes modification le 15 Mai 2007 ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUREALYS modification le 11 Septembre 2018
BODACC C Dépôts des comptes
28/08/2018
N° 20180157-8644 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
24/08/2017
N° 20170084-14300 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/06/2016
N° 20160060-9156 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC B Modifications diverses
31/07/2015
N° 20150145-2014 - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Modification de représentant. - Président : PAIJENS Cornelis Johannes modification le 15 Mai 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SARL LAUT FIDUCIAIRE modification le 15 Mai 2007 Directeur général : SOT Alain modification le 15 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUREALYS en fonction le 23 Juillet 2015
BODACC C Dépôts des comptes
30/07/2015
N° 20150069-15801 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
15/09/2014
N° 20140069-9547 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
05/09/2013
N° 20130065-13063 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
20/07/2012
N° 20120039-14383 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
26/07/2011
N° 20110040-15040 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
16/09/2010
N° 20100063-14359 Cergy Pontoise Cedex (95611) - Val-d'Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31