Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 04/08/2024

NOVATECH

En activité
SIREN 398 941 260

Adresse VOIE ANTIOPE ZI ATHELIA III 13600 LA CIOTAT

Activité Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Forme juridique SA à conseil d'administration

Création 26/05/2004

Dirigé par
EISENHUT CORINNA , EISENHUT MARCUS , MEISSNER GABRIELE , BLANCHARD JACQUET MICHEL , SEROR JEREMIE

Activité

Code APE/NAF
3250A
Libellé d'activité
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 39894126000034 Siège ouvert
VOIE ANTIOPE ZI ATHELIA III
13600 LA CIOTAT
SIRET: 39894126000018 fermé
Fermé le 01/05/2004
144 CHE DE SAINT MARC
06130 GRASSE
SIRET: 39894126000026 fermé
Fermé le 30/11/1998
AV DU VENT DES DAMES ZI LES PALUDS
13400 AUBAGNE

Dirigeants et représentants

5 Dirigeant(s) en exercice

EISENHUT CORINNA Administrateur
EISENHUT MARCUS Président du conseil d'administration et directeur général
MEISSNER GABRIELE Administrateur
BLANCHARD JACQUET MICHEL Commissaire aux comptes titulaire
SEROR JEREMIE Commissaire aux comptes suppléant

Comptes annuels 5

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 5

MN DM SPE 2024-2028 NOVATECH S.A.
Marché Fournitures
Montant: 646 120,80€
Durée: 48 mois
Notification: 30/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Fourniture d’implants maxillo-faciaux, implants...
Marché Fournitures
Montant: 42 440,00€
Durée: 36 mois
Notification: 01/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
BRONCHO.PROTH METAL DRTE TRAC
Marché Fournitures
Montant: 83 505,45€
Durée: 48 mois
Notification: 19/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
DUG 26
Marché Fournitures
Acheteur: CENTRE HOSPITAL REGION METZ THIONVILLE Établissement hospitalier
Montant: 86 240,00€
Durée: 48 mois
Notification: 13/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Le présent marché a pour objet la fourniture de...
Marché Fournitures
Montant: 7 866,40€
Durée: 48 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 16

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
05/08/2025
N° 20250148-1129 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de marseille
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
04/08/2024
N° 20240150-832 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC B Modifications diverses
30/07/2024
N° 20240146-242 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président du conseil d'administration, Directeur général : EISENHUT Marcus ; Administrateur : MEISSNER Gabriele ; Administrateur : EISENHUT Corinna ; Commissaire aux comptes titulaire : BLANCHARD JACQUET Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : SEROR Jérémie
BODACC C Dépôts des comptes
23/08/2023
N° 20230161-1133 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
26/07/2022
N° 20220143-1096 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/07/2021
N° 20210141-972 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/09/2020
N° 20200177-348 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
07/06/2019
N° 20190109-213 - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Modification de représentant. - Administrateur : EISENHUT Corinna ; Président du conseil d'administration Directeur général : EISENHUT Marcus ; Commissaire aux comptes suppléant : BROUDER Didier en fonction le 19 Octobre 2004 ; Commissaire aux comptes titulaire : EUROPCONSULT INTERNATIONAL en fonction le 19 Octobre 2004 ; Administrateur : MEISSNER Gabriele modification le 19 Avril 2018
BODACC C Dépôts des comptes
02/05/2018
N° 20180079-545 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
20/10/2014
N° 20140079-942 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
05/09/2013
N° 20130065-1386 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/09/2012
N° 20120071-1694 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/11/2011
N° 20110082-1309 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/09/2010
N° 20100068-509 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
24/09/2009
N° 20090071-500 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2008-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/09/2008
N° 20080069-877 La Ciotat (13600) - Bouches-du-Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2007-12-31