Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Président partant : GROUPE PASCAL BOULANGER ; nomination du Président : SAMSIC IV ; Directeur général partant : Wacquez, nom d'usage : Druart, Corinne
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET FORTIN
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Commissaire aux comptes titulaire partant : Bleuze, Valérie ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALTUS CONSEILS
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Président partant : Boulanger, Pascal ; nomination du Président : GROUPE PASCAL BOULANGER ; Directeur général délégué partant : Guillot Dit Salomon, nom d'usage : Boulanger, Sophie ; Directeur général délégué partant : Guillot Dit Salomon, Thierry
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
Avis initial
Acte sous seing privé en date du 09/04/2018 Service Départemental de l'Enregistrement de amiens le 11/04/2018. Adresse de l'ancien propriétaire : 5 Rue Des Indes Noires Pôle Jules Verne Amiens Est 80440 BOVES. Adresse du nouveau propriétaire : 80 bis Rue De Lambersart 59875 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à lâarticle L.141-12 du code de commerce. - Début d'activité: 2018-04-09
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Avis initial
- Délai d'opposition: 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. Acte sous séing privé en date du 04/11/2015, enregistré aux impôts le 12/11/2015 sous le n°2015/1 340 case n°1. Vendeur: SARL SNB 23 rue Denis Papin, 86100 CHATELLERAULT. Acheteur: SAS PRO IMPEC 1 rue Simon Vollant, Parc d'Activités de la Cessoie, 59130 LAMBERSAT. - Début d'activité: 2015-11-01
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31