Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

REMEA

En activité
SIREN 440 794 857

Adresse

Activité Dépollution et autres services de gestion des déchets

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 17/12/2001

Activité

Code APE/NAF
39.00Z
Libellé d'activité
Dépollution et autres services de gestion des déchets

Appels d'offres remportés en 2026 2

TRAVAUX D’EXCAVATION, D’EVACUATION ET DE TRAITE...
Marché Travaux
Montant: 500 000,00€
Durée: 3 mois
Notification: 02/04/2026
Lieu d'exécution: 13138
Procédure: Procédure adaptée
TRAVAUX D’EXCAVATION, D’EVACUATION ET DE TRAITE...
Marché Travaux
Montant: 500 000,00€
Durée: 2 mois
Notification: 26/01/2026
Lieu d'exécution: 13130
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
27/07/2025
N° 20250142-10015 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC B Modifications diverses
15/07/2025
N° 20250134-6235 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : BOURGET Franck, Georges, Claude, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes
BODACC C Dépôts des comptes
03/07/2024
N° 20240127-7643 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC B Modifications diverses
13/02/2024
N° 20240030-3348 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : BOURGET Franck, Georges, Claude, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes
BODACC C Dépôts des comptes
17/07/2023
N° 20230136-10812 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/11/2022
N° 20220220-5281 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC B Modifications diverses
03/02/2022
N° 20220024-6561 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : LACAZEDIEU Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Grange & Associes SARL de Commissariat aux Comptes
BODACC C Dépôts des comptes
17/11/2021
N° 20210223-5276 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC B Modifications diverses
22/07/2021
N° 20210141-3792 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : LACAZEDIEU Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent
BODACC C Dépôts des comptes
29/09/2020
N° 20200189-8508 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
28/01/2020
N° 20200019-4881 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/09/2018
N° 20180177-14400 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC B Modifications diverses
12/10/2017
N° 20170196-2021 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de la dénomination..
BODACC C Dépôts des comptes
05/08/2017
N° 20170072-10377 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
17/08/2016
N° 20160083-11045 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/10/2015
N° 20150105-11530 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
02/08/2014
N° 20140048-7880 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/08/2013
N° 20130050-10024 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/10/2012
N° 20120076-13578 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/09/2012
N° 20120187-1678 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. - Commissaire aux comptes titulaire : FAURE Alain Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent Président : KLEIN Pierre Yves en fonction le 19 Septembre 2012