Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

SOC LAMECOL

En activité
SIREN 304 709 256

Adresse

Activité Travaux de charpente

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/01/1974

Activité

Code APE/NAF
43.91A
Libellé d'activité
Travaux de charpente

Appels d'offres remportés en 2026 9

LOT 3 CHARPENTE BOIS MURS OSSATURES BOIS ET FAC...
Marché Travaux
Montant: 1 871 019,00€
Durée: 8 mois
Notification: 28/04/2026
Lieu d'exécution: 33980
Procédure: Appel d'offres ouvert
Le marché a pour objet la construction d’une pi...
Marché Travaux
Montant: 230 000,00€
Durée: 17 mois
Notification: 15/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Création d¿un pôle technique sur le site du pol...
Marché Travaux
Acheteur: CC TERRES TOULOISES Groupement de communes
Montant: 119 000,00€
Durée: 13 mois
Notification: 12/03/2026
Lieu d'exécution: 54200
Procédure: Procédure adaptée
Agrandissement et modernisation du musée Despia...
Marché Travaux
Montant: 955 789,04€
Durée: 42 mois
Notification: 11/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 06 OSSATURE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
Marché Travaux
Montant: 955 789,04€
Durée: 36 mois
Notification: 11/03/2026
Lieu d'exécution: 40011
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Travaux de rénovation et extension du parc-rela...
Marché Travaux
Montant: 974 000,00€
Durée: 23 mois
Notification: 08/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 02-CHARPENTE BOIS-PISCINE METROPOLITAINE
Marché Travaux
Acheteur: METZ METROPOLE Groupement de communes
Montant: 199 980,00€
Durée: 21 mois
Notification: 26/02/2026
Lieu d'exécution: 57071
Procédure: Appel d'offres ouvert
Construction d’un bâtiment d’accueil de loisirs...
Marché Travaux
Montant: 430 000,00€
Durée: 20 mois
Notification: 23/02/2026
Lieu d'exécution: 33260
Procédure: Procédure adaptée
LOT 03 CHARPENTE BOIS
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L'EYRE Groupement de communes
Montant: 85 245,00€
Durée: 17 mois
Notification: 16/02/2026
Lieu d'exécution: 33830
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
18/06/2021
N° 20210118-1804 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/10/2020
N° 20200206-4463 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
18/02/2020
N° 20200034-478 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : DEYRIS LAFOURCADELEVY Xavier, Manolo ; Directeur général : DAUDIGNY Laurent ; Directeur général délégué : CHOUZENOUX Pierre-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GEORGES BARRIERE (AGB)
BODACC B Modifications diverses
06/08/2019
N° 20190150-522 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : CHAREYRE Christian ; Directeur général : DAUDIGNY Laurent ; Directeur général délégué : CHOUZENOUX Pierre-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GEORGES BARRIERE (AGB)
BODACC C Dépôts des comptes
09/07/2019
N° 20190130-2878 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/07/2018
N° 20180125-2872 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
05/08/2017
N° 20170072-2665 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC B Modifications diverses
07/04/2017
N° 20170069-1713 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification de représentant.. - Président : CHAREYRE Christian modification le 17 Décembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE modification le 03 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GEORGES BARRIERE (AGB) en fonction le 03 Août 2016 ; Directeur général : DAUDIGNY Laurent en fonction le 04 Avril 2017
BODACC B Modifications diverses
24/01/2017
N° 20170016-792 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification du capital..
BODACC B Modifications diverses
07/08/2016
N° 20160154-389 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification de représentant.. - Président : CHAREYRE Christian modification le 17 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE modification le 03 Août 2016 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GEORGES BARRIERE (AGB) en fonction le 03 Août 2016
BODACC C Dépôts des comptes
25/07/2016
N° 20160070-1615 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC B Modifications diverses
24/09/2015
N° 20150183-630 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification de représentant. - Président : CHAREYRE Christian modification le 17 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ASSISTANCE REVISION CONTROLE en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : SALANNE Jean Marc modification le 05 Décembre 2012
BODACC B Modifications diverses
27/08/2015
N° 20150163-841 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification de représentant. - Président : CHAREYRE Christian modification le 17 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ASSISTANCE REVISION CONTROLE en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : SALANNE Jean Marc modification le 05 Décembre 2012 Directeur général : SOLER Guillaume modification le 17 Août 2012
BODACC C Dépôts des comptes
18/07/2015
N° 20150060-2176 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
16/08/2014
N° 20140056-3713 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC B Modifications diverses
15/08/2014
N° 20140155-491 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification du capital.
BODACC B Modifications diverses
07/08/2013
N° 20130151-817 Canéjan (33610) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification de l'adresse du siège.
BODACC C Dépôts des comptes
25/07/2013
N° 20130042-3090 Mérignac (33700) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC B Modifications diverses
13/12/2012
N° 20120241-154 - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Modification de l'activité. Modification de représentant. - Président : CHAREYRE Christian modification le 17 Décembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ASSISTANCE REVISION CONTROLE en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : SALANNE Jean Marc modification le 05 Décembre 2012 Directeur général : SOLER Guillaume modification le 17 Août 2012 Directeur général délégué : GERVAIS Jean-Baptiste René Roger en fonction le 22 Mars 2012
BODACC C Dépôts des comptes
14/08/2012
N° 20120048-2280 Mérignac (33700) - Gironde
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31