Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)

En activité
SIREN 509 349 494

Adresse

Activité Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 04/12/2008

Activité

Code APE/NAF
20.30Z
Libellé d'activité
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Appels d'offres remportés en 2026 22

Achat de produits de marquage routier pour trav...
Marché Fournitures
Acheteur: COLLECTIVITE DE CORSE Région
Montant: 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 14/04/2026
Lieu d'exécution: 20187
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS DE MARQUAGE...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L AIN Département
Montant: 1 500 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE POUR LES TRA...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE Département
Montant: 400 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 31/03/2026
Lieu d'exécution: 37000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot n°2 Enduits à froid et produits préfabriqué...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L ALLIER Département
Montant: 252 780,00€
Durée: 48 mois
Notification: 16/03/2026
Lieu d'exécution: 03000
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - LO...
Marché Fournitures
Montant: 40 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 22700
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - LO...
Marché Fournitures
Montant: 80 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 22700
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER - LO...
Marché Fournitures
Montant: 120 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 22700
Procédure: Appel d'offres ouvert
Peinture Routière
Marché Fournitures
Montant: 50 400,00€
Durée: 1 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 66704
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE MARQUAGE ROUTIER - LOT 04 PRODUIT...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DES LANDES Département
Montant: 320 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE MARQUAGE ROUTIER - LOT 05 BANDES...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DES LANDES Département
Montant: 320 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
25050PRP - Fourniture de produits divers pour l...
Marché Fournitures
Acheteur: CU LE CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES Groupement de communes
Montant: 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 24/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Produits et matériels de marquage routier
Marché Fournitures
Montant: 50 000,00€
Durée: 23 mois
Notification: 23/02/2026
Lieu d'exécution: 83240
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE POUR LES ROU...
Marché Fournitures
Montant: 220 000,00€
Durée: 24 mois
Notification: 19/02/2026
Lieu d'exécution: 49000
Procédure: Procédure adaptée
FOURNITURE DE PRODUITS DE SIGNALISATION HORIZON...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DU VAUCLUSE Département
Montant: 216 000,00€
Durée: 47 mois
Notification: 09/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE AU SOL
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNE DE MACON (MAIRIE) Commune
Montant: 200 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 23/01/2026
Lieu d'exécution: 71018
Procédure: Procédure adaptée
FOURNITURE DE MATERIAUX DE BATIMENT ET VOIRIE...
Marché Fournitures
Acheteur: CA DU BEAUVAISIS Groupement de communes
Montant: 41 800,00€
Durée: 48 mois
Notification: 22/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
FOURNITURE DE MATERIAUX DE BATIMENT ET VOIRIE...
Marché Fournitures
Montant: 209 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 22/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 2: Produits thermocollés
Marché Fournitures
Montant: 40 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 16/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
FOURNITURE DE PRODUITS DE MARQUAGE POUR REVÊTEM...
Marché Fournitures
Montant: 89 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 08/01/2026
Lieu d'exécution: 13657
Procédure: Procédure adaptée
LOT1 ENDUIT A FROID BI COMPOSANT
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE LA CHARENTE Département
Montant: 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 07/01/2026
Lieu d'exécution: 16000
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT4 PEINTURE AQUEUSE
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE LA CHARENTE Département
Montant: 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 07/01/2026
Lieu d'exécution: 16000
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 6 PEINTURE ET MARQUAGE ROUTIER
Marché Fournitures
Acheteur: CA GRAND CHATELLERAULT (MAGASIN GENERAL) Groupement de communes
Montant: 500 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 06/01/2026
Lieu d'exécution: 86106
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC B Modifications diverses
02/09/2025
N° 20250167-3402 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : CHEVALLIER François ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
BODACC C Dépôts des comptes
06/08/2025
N° 20250149-10415 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/07/2024
N° 20240134-6923 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/11/2023
N° 20230224-7529 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/06/2022
N° 20220118-7979 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC B Modifications diverses
23/12/2021
N° 20210249-4422 Rueil-Malmaison (92500) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
transfert du siège social. - Président : CHEVALLIER François ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC B Modifications diverses
09/09/2021
N° 20210176-2221 Nanterre, Agnetz (92000, 60600) - Oise
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Avis initial
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
BODACC C Dépôts des comptes
17/08/2021
N° 20210159-6007 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC B Modifications diverses
06/08/2020
N° 20200151-4091 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : CHEVALLIER François ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC C Dépôts des comptes
06/08/2020
N° 20200151-21942 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/08/2019
N° 20190155-11127 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/08/2018
N° 20180148-14837 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
08/06/2017
N° 20170047-8244 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC B Modifications diverses
08/12/2016
N° 20160239-1755 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant.. - Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 14 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 14 Juillet 2011 ; Président : CHEVALLIER François en fonction le 05 Décembre 2016
BODACC C Dépôts des comptes
11/08/2016
N° 20160080-10679 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC B Modifications diverses
15/09/2015
N° 20150176-830 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant. - Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 14 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 14 Juillet 2011 Président : GINTER Patrick en fonction le 04 Septembre 2015
BODACC C Dépôts des comptes
31/08/2015
N° 20150086-11739 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC B Modifications diverses
24/03/2015
N° 20150058-1847 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant. - Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 14 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 14 Juillet 2011 Président : DESCHANEL Didier en fonction le 16 Mars 2015
BODACC C Dépôts des comptes
16/08/2014
N° 20140056-15800 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC B Modifications diverses
22/06/2014
N° 20140118-974 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de l'adresse du siège.