Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

SOCIETE MALEINGE

En activité
SIREN 324 631 274

Adresse

Activité Travaux de revêtement des sols et des murs

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/01/1964

Activité

Code APE/NAF
43.33Z
Libellé d'activité
Travaux de revêtement des sols et des murs

Appels d'offres remportés en 2026 14

LOT07 CARRELAGE FAIENCE
Marché Travaux
Montant: 79 800,00€
Durée: 18 mois
Notification: 02/04/2026
Lieu d'exécution: 44110
Procédure: Procédure adaptée
Lot 11 : REVETEMENTS DE SOLS DURS
Marché Travaux
Acheteur: ALTER PUBLIC
Montant: 139 432,35€
Durée: 25 mois
Notification: 02/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT9- Chape- carrelage- faïence
Marché Travaux
Montant: 64 302,85€
Durée: 21 mois
Notification: 17/03/2026
Lieu d'exécution: 49500
Procédure: Procédure adaptée
CARRELAGE / FAIENCE - Construction de l’école...
Marché Travaux
Montant: 55 428,65€
Durée: 15 mois
Notification: 12/03/2026
Lieu d'exécution: 49000
Procédure: Procédure adaptée
CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOU...
Marché Travaux
Montant: 41 000,00€
Durée: 12 mois
Notification: 11/03/2026
Lieu d'exécution: 49800
Procédure: Procédure adaptée
Travaux de rénovation partielle du complexe spo...
Marché Travaux
Montant: 8 477,00€
Durée: 7 mois
Notification: 23/02/2026
Lieu d'exécution: 44980
Procédure: Procédure adaptée
LOT 13 CARRELAGE MSP LA PERRIERE
Marché Travaux
Montant: 83 900,00€
Durée: 21 mois
Notification: 17/02/2026
Lieu d'exécution: 53204
Procédure: Procédure adaptée
Construction d’un centre d’incendie et de secou...
Marché Travaux
Montant: 41 000,00€
Durée: 12 mois
Notification: 17/02/2026
Lieu d'exécution: 49800
Procédure: Procédure adaptée
Lot 9 - REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX
Marché Travaux
Acheteur: ALTER PUBLIC
Montant: 37 370,40€
Durée: 20 mois
Notification: 13/02/2026
Lieu d'exécution: 49
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 12 - Carrelage - Faïence
Marché Travaux
Acheteur: ANGERS LOIRE HABITAT EPIC
Montant: 70 900,00€
Durée: 34 mois
Notification: 10/02/2026
Lieu d'exécution: 49
Procédure: Procédure adaptée
REST SCOL LOT 13 REVETEMENTS DE SOLS CERAMIQUES...
Marché Travaux
Montant: 43 339,00€
Durée: 13 mois
Notification: 05/02/2026
Lieu d'exécution: 85480
Procédure: Procédure adaptée
AMENAGEMENT D’UN TAGV A BEAUCOUZE - LOT 06 - CA...
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE Groupement de communes
Montant: 50 782,62€
Durée: 10 mois
Notification: 03/02/2026
Lieu d'exécution: 49070
Procédure: Procédure adaptée
Carrelage - faïence - Construction d’un bâtimen...
Marché Travaux
Acheteur: CC ANJOU BLEU COMMUNAUTE Groupement de communes
Montant: 8 400,00€
Durée: 12 mois
Notification: 28/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Réhabilitation du centre d’incendie et de secou...
Marché Travaux
Montant: 30 742,00€
Durée: 12 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution: 49071
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
13/11/2025
N° 20250218-4441 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
Greffe du Tribunal de Commerce d'angers
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/03/2025
N° 20250050-4609 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
Greffe du Tribunal de Commerce d'angers
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/10/2023
N° 20230204-2332 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
Greffe du Tribunal de Commerce d'angers
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/10/2022
N° 20220203-3644 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
Greffe du Tribunal de Commerce d'angers
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
10/11/2021
N° 20210219-2341 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/11/2020
N° 20200221-3188 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
14/01/2020
N° 20200009-952 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : MALEINGE Thierry ; Directeur général : MARTINEAU Maryline
BODACC C Dépôts des comptes
24/12/2019
N° 20190247-3767 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
06/03/2019
N° 20190046-1806 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
07/11/2017
N° 20170110-6022 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
05/12/2016
N° 20160129-3181 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
07/10/2014
N° 20140076-3666 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/10/2012
N° 20120078-6032 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
20/08/2011
N° 20110048-6869 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31
BODACC B Modifications diverses
07/07/2010
N° 20100130-724 - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Modification survenue sur le capital
BODACC C Dépôts des comptes
18/11/2009
N° 20090086-3854 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2008-12-31
BODACC B Modifications diverses
29/07/2009
N° 20090143-822 - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Modification survenue sur le capital
BODACC C Dépôts des comptes
19/08/2008
N° 20080057-5919 Saint-Pierre-Montlimart (49110) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2007-12-31
BODACC B Modifications diverses
03/08/2008
N° 20080136-639 - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : MALEINGE ThierryDirecteur général : MARTINEAU Maryline né(e) MALEINGE. Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : VION Gérard.
BODACC B Modifications diverses
03/08/2008
N° 20080136-640 - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
Modification survenue sur le capital