Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 17/03/2026

SORELUM

En activité
SIREN 483 184 388

Adresse

Activité Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 27/06/2005

Activité

Code APE/NAF
42.22Z
Libellé d'activité
Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Appels d'offres remportés en 2026 8

Travaux de désimperméabilisation et végétalisat...
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNE DE LAVAL (MAIRIE) Commune
Montant: 119 380,50€
Durée: 18 mois
Notification: 27/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA TRANCHE N°3 DE LA Z...
Marché Travaux
Acheteur: TERRE ET TOIT
Montant: -18 764,60€
Durée: 79 mois
Notification: 03/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
TRAVAUX DE RESEAUX EXTENSIONS EFFACEMENTS RENFO...
Marché Travaux
Acheteur: TERRITOIRE D'ENERGIE MAYENNE Syndicat mixte
Montant: 1 700 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 31/03/2026
Lieu d'exécution: 53810
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 2 : Réseaux souples
Marché Travaux
Acheteur: ALTER CITES
Montant: 167 663,70€
Durée: 13 mois
Notification: 23/03/2026
Lieu d'exécution: 49
Procédure: Procédure adaptée
MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNE DE CRAON (MAIRIE) Commune
Montant: 152 789,90€
Durée: 8 mois
Notification: 19/02/2026
Lieu d'exécution: 53400
Procédure: Procédure adaptée
TRAVAUX ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNE D'EVRON (MAIRIE) Commune
Montant: 1 800 000,00€
Durée: 47 mois
Notification: 13/02/2026
Lieu d'exécution: 53600
Procédure: Procédure adaptée
Travaux d’éclairage public et entretien-mainten...
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNE D'EVRON (MAIRIE) Commune
Montant: 1 800 000,00€
Durée: 11 mois
Notification: 13/02/2026
Lieu d'exécution: 53600
Procédure: Procédure adaptée
Travaux d’aménagement de 3 terrains synthétique...
Marché Travaux
Acheteur: LAVAL AGGLOMERATION Groupement de communes
Montant: 282 091,00€
Durée: 24 mois
Notification: 12/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC B Modifications diverses
08/01/2026
N° 20260004-1446 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de Laval
Avis initial
Modification survenue sur le capital.
BODACC C Dépôts des comptes
09/09/2025
N° 20250172-3310 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
08/08/2024
N° 20240153-6014 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC B Modifications diverses
16/07/2024
N° 20240136-1354 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de Laval
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : TRAVAUX PUBLICS DU BLAVET ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE SECOB LORIENT
BODACC C Dépôts des comptes
25/07/2023
N° 20230141-3710 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/12/2022
N° 20220251-1177 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de Laval
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : TRAVAUX PUBLICS DU BLAVET ; Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES ; Commissaire aux comptes suppléant : EL AMRANI Abdelmajid
BODACC C Dépôts des comptes
13/12/2022
N° 20220241-2157 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/05/2022
N° 20220094-2191 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-03-31
BODACC B Modifications diverses
31/05/2021
N° 20210105-1177 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : MIRALY ; Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES ; Commissaire aux comptes suppléant : EL AMRANI Abdelmajid
BODACC C Dépôts des comptes
29/12/2020
N° 20200252-3917 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-03-31
BODACC B Modifications diverses
04/02/2020
N° 20200024-1684 - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : FINANCIERE LOREMIRE (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : EL AMRANI Abdelmajid
BODACC B Modifications diverses
31/12/2019
N° 20190251-1227 - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : GILIMER (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : CIGEST FINANCES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : EL AMRANI Abdelmajid
BODACC C Dépôts des comptes
24/12/2019
N° 20190247-4579 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
27/11/2018
N° 20180221-4885 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
07/03/2018
N° 20180042-1516 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
01/12/2017
N° 20170118-6352 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-03-31
BODACC B Modifications diverses
22/12/2016
N° 20160249-1812 Saint-Berthevin (53940) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Modification survenue sur la dénomination et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
BODACC C Dépôts des comptes
10/10/2016
N° 20160108-8364 Saint-Pierre-la-Cour (53410) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
03/06/2016
N° 20160053-3362 Saint-Pierre-la-Cour (53410) - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-03-31
BODACC B Modifications diverses
16/04/2015
N° 20150074-895 - Mayenne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : GILIMER (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : RSM OUEST AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Benoîst