Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

THERMOSANI

En activité
SIREN 390 636 413

Adresse

Activité Travaux de couverture par éléments

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 01/01/1993

Activité

Code APE/NAF
43.91B
Libellé d'activité
Travaux de couverture par éléments

Appels d'offres remportés en 2026 3

lot 2 ITE - étanchéité
Marché Travaux
Montant: 260 043,27€
Durée: 24 mois
Notification: 09/04/2026
Lieu d'exécution: 91440
Procédure: Procédure adaptée
Travaux de restructuration des locaux de la hal...
Marché Travaux
Montant: 19 987,93€
Durée: 4 mois
Notification: 06/02/2026
Lieu d'exécution: 77330
Procédure: Procédure adaptée
Travaux de restructuration des locaux de la hal...
Marché Travaux
Montant: 19 987,93€
Durée: 4 mois
Notification: 06/02/2026
Lieu d'exécution: 77330
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
17/09/2025
N° 20250178-3763 Servon (77170) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/01/2025
N° 20250013-3699 Servon (77170) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
24/11/2023
N° 20230227-4957 Servon (77170) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/08/2022
N° 20220159-14124 Servon (77170) - Seine-et-Marne
Greffe du Tribunal de Commerce de melun
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/07/2021
N° 20210143-6549 Servon (77170) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/08/2020
N° 20200159-6276 Servon (77170) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
09/08/2020
N° 20200153-2672 Servon (77170) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : LE PIRONNEC Franck, Raoul, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : ALF ; Commissaire aux comptes suppléant : PELLIEUX Didier
BODACC A Immatriculations
10/09/2019
N° 20190174-1920 Servon (77170) - Seine-et-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Avis initial
Modification survenue sur l'activité, immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. - Début d'activité: 1993-01-01 - Président : VECCHIONE Marisa ; Commissaire aux comptes titulaire : ALF ; Commissaire aux comptes suppléant : PELLIEUX Didier
BODACC C Dépôts des comptes
26/07/2019
N° 20190143-4767 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/08/2018
N° 20180148-17911 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
17/08/2017
N° 20170080-13734 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/07/2016
N° 20160074-11723 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/07/2015
N° 20150058-17812 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC B Modifications diverses
10/06/2015
N° 20150109-4472 - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Modification de représentant. - Commissaire aux comptes titulaire : ALF en fonction le 09 Février 2004 Commissaire aux comptes suppléant : PELLIEUX Didier en fonction le 09 Février 2004 Président : TAVOLIERI Marisa en fonction le 02 Juin 2015
BODACC C Dépôts des comptes
25/08/2014
N° 20140059-11889 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
02/08/2013
N° 20130047-15133 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/09/2012
N° 20120071-15702 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC A Procédures collectives
03/02/2012
N° 20120044-1715 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Procédures collectives
BODACC C Dépôts des comptes
19/08/2011
N° 20110047-12315 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/11/2010
N° 20100088-13536 Vitry-sur-Seine (94400) - Val-de-Marne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31