Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 06/07/2024

ACIAL

En activité
SIREN 595 820 374

Adresse 14 RTE DU BLANC 41110 SAINT-AIGNAN

Activité Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 19/08/1958

Dirigé par
IN EXTENSO IDF AUDIT , OPTIMUS BIDCO SA

Activité

Code APE/NAF
3101Z
Libellé d'activité
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 59582037400014 Siège ouvert
14 RTE DU BLANC
41110 SAINT-AIGNAN
SIRET: 59582037400022 ouvert
RTE NATIONALE76
41140 NOYERS-SUR-CHER
SIRET: 59582037400055 ouvert
RTE DE LA TRIMOUILLE ZONE INDUSTRIELLE
86500 MONTMORILLON
SIRET: 59582037400105 ouvert
8 RUE CLAUDE CHAPPE
57070 METZ
SIRET: 59582037400113 ouvert
1 RUE CHARLES LINDBERGH
44340 BOUGUENAIS
SIRET: 59582037400121 fermé
Fermé le 18/10/2006
RTE DE ST GIROD ZA
73410 ENTRELACS
SIRET: 59582037400097 fermé
Fermé le 05/09/2002
57 RUE DES SAULES
75018 PARIS
SIRET: 59582037400071 fermé
Fermé le 30/11/1999
6 ESPACE HENRY VALLEE
69007 LYON
SIRET: 59582037400063 fermé
Fermé le 25/12/1994
70 RUE AMELOT
75011 PARIS
SIRET: 59582037400089 fermé
Fermé le 01/01/1994
44 RUE MAURICE DE BROGLIE ZAC DES MARDELLES
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Dirigeants et représentants

2 Dirigeant(s) en exercice

IN EXTENSO IDF AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 392437356
OPTIMUS BIDCO SA Président de SAS
 SIREN: 840729818

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2022 13

Accords-cadres à bons de commande pour la fourn...
Marché Fournitures
Acheteur: VILLE DE PARIS (MAIRIE) Commune
Montant: 0,00€
Durée: 48 mois
Notification: 04/10/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de mobilier spécifique pour les loca...
Accord-cadre Fournitures
Montant: 214 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 04/10/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
SA1-FOURNITURE POSE MOBILIERS METALLIQUES SERVI...
MARCHE Fournitures
Acheteur: VILLE DE PARIS (MAIRIE) Commune
Montant: 3 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 04/10/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de mobilier spécifique pour les loca...
ACCORD-CADRE Fournitures
Montant: 25 392,31€
Durée: 12 mois
Notification: 04/10/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Mobiliers de sécurité, rayonnages, mobiliers et...
Marché Fournitures
Montant: 0,00€
Durée: 48 mois
Notification: 29/09/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
21-2299-1-07 Equipement en mobilier lot n° 7 Ra...
Accord-cadre Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L' ESSONNE Département
Montant: 160 000,00€
Durée: 24 mois
Notification: 19/07/2022
Lieu d'exécution: 91000
Procédure: Appel d'offres ouvert
21-2299-1-07 Equipement en mobilier lot n° 7 Ra...
Accord-cadre Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L' ESSONNE Département
Montant: 160 000,00€
Durée: 24 mois
Notification: 19/07/2022
Lieu d'exécution: 91000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de casiers pour 6 collèges du Départ...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE Département
Montant: 24 386,16€
Durée: 2 mois
Notification: 25/05/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
21-2299-1-06 Equipement en mobiliers Lot 6 : mo...
Accord-cadre Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L' ESSONNE Département
Montant: 600 000,00€
Durée: 24 mois
Notification: 24/05/2022
Lieu d'exécution: 91000
Procédure: Appel d'offres ouvert
ACQUISITION DE MOBILIERS LOT 9- MOBILIER D’ATEL...
Accord-cadre Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DU VAUCLUSE Département
Montant: 579 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 10/05/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
DAF_2021_000016-Lot 6 : Mobiliers d’ateliers
ACCORD-CADRE Fournitures
Montant: 26 693 537,00€
Durée: 12 mois
Notification: 14/03/2022
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 07 - CASIERS SCOLAIRES VESTIAIRES MOBILIER...
Accord-cadre Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L HERAULT Département
Montant: 940 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 15/02/2022
Lieu d'exécution: 34000
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 07 - CASIERS SCOLAIRES VESTIAIRES MOBILIER...
Accord-cadre Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L HERAULT Département
Montant: 940 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 15/02/2022
Lieu d'exécution: 34000
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 18

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
01/08/2025
N° 20250146-3554 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/01/2025
N° 20250006-5553 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
17/08/2023
N° 20230157-3701 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC B Modifications diverses
26/01/2023
N° 20230018-1333 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de Blois
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : OPTIMUS BIDCO SA ; Commissaire aux comptes : IN EXTENSO IDF AUDIT
BODACC C Dépôts des comptes
11/08/2022
N° 20220155-7409 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/09/2021
N° 20210184-2255 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/11/2020
N° 20200233-2874 Saint-Aignan (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
10/10/2019
N° 20190196-1979 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
06/09/2018
N° 20180164-4332 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC B Modifications diverses
01/12/2017
N° 20170231-1005 - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : AVERYS (SA) représenté par DE VUYST Jos ; Commissaire aux comptes : IN EXTENSO IDF AUDIT (SAS)
BODACC C Dépôts des comptes
31/10/2017
N° 20170108-2081 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
19/07/2016
N° 20160067-4668 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
15/09/2015
N° 20150094-3801 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
12/08/2014
N° 20140054-8975 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
26/08/2009
N° 20090059-7948 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2008-12-31
BODACC A Procédures collectives
23/06/2009
N° 20090118-1278 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Procédures collectives
BODACC C Dépôts des comptes
25/09/2008
N° 20080072-5528 Saint-Aignan-sur-Cher (41110) - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2007-12-31
BODACC B Modifications diverses
13/02/2008
N° 20080027-1698 - Loir-et-Cher
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : AVERYS (SA) représenté par PERREAUX Jean-Dominique François-Alfred. Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE LEYDET (SA). Commissaire aux comptes suppléant : BURGUIERE Cédric.