Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

GEOUEST

En activité
SIREN 480 365 956

Adresse

Activité Activité des géomètres

Forme juridique Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

Création 24/12/2004

Activité

Code APE/NAF
71.12A
Libellé d'activité
Activité des géomètres

Appels d'offres remportés en 2026 10

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement urbain du...
Marché Services
Montant: 22 995,00€
Durée: 8 mois
Notification: 18/03/2026
Lieu d'exécution: 85190
Procédure: Procédure adaptée
LOT 5 SECTEURS VALLEE DU MARILLET - LA ROCHE SU...
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 1 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 7 SECTEUR VALLEE DE LA SEVRE
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 800 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 8 SECTEUR DEUX MAINES
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 1 200 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 9 SECTEURS ANGLE GUIGNARD-ROCHEREAU
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 1 600 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 4 HAUTE VALLLE DE LA VIE
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 300 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 5 VALLEE DU MARILLET ET LA ROCHE SUR YON
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 300 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 8 DEUX MAINES
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 300 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 9 ANGLE GUIGNARD ET ROCHEREAU
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 300 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation
LOT 7 VALLEE DE LA SEVRE
Marché Services
Acheteur: VENDEE EAU Syndicat mixte
Montant: 400 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 85036
Procédure: Procédure avec négociation

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC B Modifications diverses
10/02/2026
N° 20260027-6871 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Avis initial
modification survenue sur l'administration - modification du Gérant David, Grégory ; modification du Commissaire aux comptes GROUPE Y
BODACC B Modifications diverses
18/09/2024
N° 20240181-2159 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Avis initial
modification survenue sur l'administration - Commissaire aux comptes titulaire partant : ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y
BODACC B Modifications diverses
25/01/2024
N° 20240017-4072 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Avis initial
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
BODACC C Dépôts des comptes
08/12/2021
N° 20210238-5155 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/07/2020
N° 20200140-4525 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
21/01/2020
N° 20200014-4465 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
modification survenue sur l'administration - nomination du Gérant : Voyer, Maxime
BODACC C Dépôts des comptes
30/07/2019
N° 20190145-10169 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC B Modifications diverses
17/07/2019
N° 20190136-1798 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
modification survenue sur la dénomination
BODACC C Dépôts des comptes
31/07/2018
N° 20180138-12757 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC B Modifications diverses
20/07/2018
N° 20180136-1441 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
modification survenue sur l'administration - modification du Commissaire aux comptes titulaire ACCIOR LA ROCHE SUR YON ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Andre, Valérie
BODACC B Modifications diverses
11/02/2018
N° 20180029-3497 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
modification survenue sur l'administration - modification du Gérant Susset, Christophe Jean Dominique Marie ; modification du Gérant Chabot, Sylvain
BODACC C Dépôts des comptes
09/08/2017
N° 20170075-11323 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/08/2016
N° 20160080-7957 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/01/2016
N° 20160004-3021 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
07/06/2014
N° 20140032-11441 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC B Modifications diverses
06/02/2014
N° 20140026-1648 - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Modification du nom commercial.
BODACC C Dépôts des comptes
06/09/2011
N° 20110053-7325 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31
BODACC B Modifications diverses
22/02/2011
N° 20110037-2276 L'Ile-d'Yeu (85350) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Changement de dénomination sociale Nomination comme gérant : CHABOT Sylvain - Gérant : SUSSET Christophe Jean Dominique Marie Gérant : DAVID Grégory Gérant : CHABOT Sylvain Commissaire aux comptes titulaire : ACCESS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Valérie
BODACC C Dépôts des comptes
03/09/2010
N° 20100053-10902 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2009-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
21/08/2009
N° 20090057-9443 La Roche-sur-Yon (85000) - Vendée
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2008-12-31