Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Insee : 06/12/2025

SOURCES

En activité
SIREN 432 937 464

Adresse

Activité Ingénierie, études techniques

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 02/10/2000

Activité

Code APE/NAF
71.12B
Libellé d'activité
Ingénierie, études techniques

Appels d'offres remportés en 2026 10

RENOVATION DE L ATELIER DE DESHYDRATATION DES B...
Marché Travaux
Acheteur: CA GAP-TALLARD-DURANCE (ASSAINISSEMENT) Groupement de communes
Montant: 1 983 600,00€
Durée: 10 mois
Notification: 10/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
LOT 1 STATION D EPURATION MAULEVRIER
Marché Travaux
Acheteur: CA CHOLET AGGLOMERATION (ASSAINISSEMENT) Groupement de communes
Montant: 3 121 345,25€
Durée: 24 mois
Notification: 23/03/2026
Lieu d'exécution: 49321
Procédure: Procédure adaptée
RENOUVELLEMENT STATION EPURATION
Marché Travaux
Montant: 852 900,00€
Durée: 11 mois
Notification: 19/03/2026
Lieu d'exécution: 84201
Procédure: Procédure adaptée
CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STATION DE TRAITEME...
Marché Travaux
Montant: 6 672 507,00€
Durée: 30 mois
Notification: 16/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure avec négociation
RENOVATION STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES...
Marché Fournitures
Montant: 1 245 200,00€
Durée: 28 mois
Notification: 04/03/2026
Lieu d'exécution: 43300
Procédure: Procédure adaptée
RECONSTRUCTION STATION DE TRAITEMENT DES EAUX U...
Marché Travaux
Montant: 1 045 000,00€
Durée: 9 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution: 73220
Procédure: Procédure adaptée
Conception et réalisation d’une station d’épura...
Marché Fournitures
Acheteur: RENNES METROPOLE Groupement de communes
Montant: 43 985 000,00€
Durée: 72 mois
Notification: 02/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure avec négociation
ST CRICQ CHALOSSE CONSTRUCTION STEP
Marché Travaux
Montant: 600 905,00€
Durée: 4 mois
Notification: 24/02/2026
Lieu d'exécution: 40700
Procédure: Procédure adaptée
NVELLE USINE PROD EP DE MEDOUS ET DECONSTR USIN...
Marché Travaux
Montant: 7 782 600,00€
Durée: 365 mois
Notification: 22/01/2026
Lieu d'exécution: 65000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Modernisation de la file boue et mise en place...
Marché Travaux
Montant: 817 957,00€
Durée: 24 mois
Notification: 16/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC B Modifications diverses
29/07/2025
N° 20250143-5653 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SOURCES HORIZONS ; Commissaire aux comptes titulaire : DE COURCEL Benjamin ; Commissaire aux comptes suppléant : KERNER MORIN Lara
BODACC C Dépôts des comptes
17/06/2025
N° 20250114-9980 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/09/2024
N° 20240184-7851 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
13/07/2023
N° 20230134-11894 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
16/08/2022
N° 20220158-8580 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
14/09/2021
N° 20210179-5851 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/06/2020
N° 20200120-4899 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
17/09/2019
N° 20190179-6606 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC B Modifications diverses
05/05/2019
N° 20190087-3228 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de la forme juridique.Modification de représentant. - Commissaire aux comptes suppléant : KERNER, KERNER MORIN Lara en fonction le 22 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DE COURCEL Benjamin en fonction le 22 Octobre 2018 ; Président : Manon SAS en fonction le 02 Mai 2019
BODACC B Modifications diverses
24/10/2018
N° 20180203-2393 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant. - Président du conseil d'administration : BILLETTE Patrick en fonction le 28 Septembre 2000 ; Administrateur : TRIAU Jean Luc en fonction le 28 Septembre 2000 ; Commissaire aux comptes titulaire : BATAILLE Jean Pierre en fonction le 28 Septembre 2000 ; Commissaire aux comptes suppléant : RANDON Jean Luc en fonction le 28 Septembre 2000 ; Administrateur : MOTHERON Corinne en fonction le 04 Janvier 2005
BODACC B Modifications diverses
24/10/2018
N° 20180203-2394 - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification de représentant. - Président du conseil d'administration : BILLETTE Patrick en fonction le 28 Septembre 2000 ; Administrateur : TRIAU Jean Luc en fonction le 28 Septembre 2000 ; Administrateur : MOTHERON Corinne en fonction le 04 Janvier 2005 ; Commissaire aux comptes suppléant : KERNER Lara en fonction le 22 Octobre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : DE COURCEL Benjamin en fonction le 22 Octobre 2018
BODACC A Ventes et cessions
28/08/2018
N° 20180162-672 Nanterre, Chemille-en-Anjou (92000, 49120) - Maine-et-Loire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Avis initial
suivant acte ssp signé à Paris en date du 13 juillet 2018, enregistré au SIE de Cholet, le 26/07/2018 bordereau n° 2018/390 Case n° 8 Ext 1008 - adresse du précédent propriétaire : 101 avenue du Général de Gaulle Chemillé Melay 49120 Chemillé en Anjou - Début d'activité: 2018-07-01
BODACC C Dépôts des comptes
26/06/2018
N° 20180115-6339 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/07/2017
N° 20170065-8262 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
18/11/2016
N° 20160123-8777 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
27/06/2015
N° 20150054-9661 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
31/10/2014
N° 20140081-12991 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
22/07/2013
N° 20130039-14202 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/07/2012
N° 20120036-13808 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2011-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
31/10/2011
N° 20110076-12458 Nanterre (92000) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2010-12-31