Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 18/12/2025

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE

En activité
SIREN 333 321 636

Adresse 244 RTE DE SEYSSES 31100 TOULOUSE

Activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 27/08/1985

Dirigé par
SHIGENOBU NAGAO , TOMOTA YOICHI , SODECAL AUDIT

Activité

Code APE/NAF
4666Z
Libellé d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Objet
Achat, vente de tout matériel et fournitures de bureau. Entretien et réparation desdits matériels et fournitures de bureau, reprographie, toute activité avant vente : étude, audit, conseils se rapportant à ces activités. Toutes activités après vente : délégations de taches ou de personnes, prise en charge de services externalisés. Toutes activités financières, toutes activités de formation se rapportant au matériel distribué par la société et au domaine informatique.
Date de clôture d'exercice
31/03

Établissements de l'entreprise

SIRET: 33332163600586 Siège ouvert
244 RTE DE SEYSSES
31100 TOULOUSE
SIRET: 33332163600461 ouvert
31 AV GUSTAVE EIFFEL BATIMENT B1 EDISON PARK
33600 PESSAC
SIRET: 33332163600479 ouvert
22 AV DES NATIONS PARC D AFFAIRES SILIC PARIS NORD 2
93420 VILLEPINTE
SIRET: 33332163600503 ouvert
LE TREIL
47520 LE PASSAGE
SIRET: 33332163600511 ouvert
97 RUE DE FREYR PARC EUREKA
34000 MONTPELLIER
SIRET: 33332163600552 ouvert
35 CRS GOUFFE
13006 MARSEILLE
SIRET: 33332163600594 ouvert
550 RUE PIERRE BERTHIER L OLIVIER EUROPARC DE PICHAURY
13290 AIX-EN-PROVENCE
SIRET: 33332163600628 ouvert
93 RUE DE LA VILLETTE LYON PLAZA BUSINESS CENTRE
69003 LYON
SIRET: 33332163600636 ouvert
5 RUE DES TIREDOUS 5-7-ZAC DU PARKWAY
64000 PAU
SIRET: 33332163600644 ouvert
2 RUE Claude Chappe Regus Cesson
35510 Cesson-Sévigné
SIRET: 33332163600610 fermé
Fermé le 06/01/2025
20 RUE D'ISLY IMMEUBLE 3 SOLEILS
35000 RENNES
SIRET: 33332163600255 fermé
Fermé le 21/06/2023
18 RUE ROGER SALENGRO PARC D'ACTIVITES PYRENEES
64000 PAU
SIRET: 33332163600602 fermé
Fermé le 01/08/2021
18 RUE TRONCHET
69006 LYON
SIRET: 33332163600487 fermé
Fermé le 31/12/2020
1 CRS ALBERT THOMAS
69003 LYON
SIRET: 33332163600537 fermé
Fermé le 31/12/2020
75 CRS GOUFFE
13006 MARSEILLE
SIRET: 33332163600545 fermé
Fermé le 31/12/2020
30 PL ANTIGONE LE PARC DE LA BAOU
83110 SANARY SUR MER
SIRET: 33332163600495 fermé
Fermé le 01/10/2020
12 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE IMMEUBLE LES PORTES SUD
31100 TOULOUSE
SIRET: 33332163600578 fermé
Fermé le 31/12/2019
4 RUE DE MICY PORTE DE MICY
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
SIRET: 33332163600560 fermé
Fermé le 08/03/2017
85 AV DU GENERAL DE GAULLE
32500 FLEURANCE
SIRET: 33332163600529 fermé
Fermé le 30/04/2016
22 AV DES NATIONS ZAC PARIS NORD 2
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
SIRET: 33332163600339 fermé
Fermé le 31/03/2015
2 RUE ST JEAN RESIDENCE MICHELET
65000 TARBES
SIRET: 33332163600438 fermé
Fermé le 31/07/2014
65 AV JEAN MERMOZ
93120 LA COURNEUVE
SIRET: 33332163600016 fermé
Fermé le 01/10/2013
20 RUE THERON DE MONTAUGE
31200 TOULOUSE
SIRET: 33332163600446 fermé
Fermé le 30/09/2013
IMP CHARLES FOURIER PARC D'ACTIVITES AFTALION
34670 BAILLARGUES
SIRET: 33332163600321 fermé
Fermé le 06/06/2012
42 CRS ALSACE LORRAINE
24100 BERGERAC
SIRET: 33332163600073 fermé
Fermé le 01/06/2012
45 AV EMILIE DE VILLENEUVE
81100 CASTRES
SIRET: 33332163600081 fermé
Fermé le 01/06/2012
PL ST URSULE
09100 PAMIERS
SIRET: 33332163600099 fermé
Fermé le 01/06/2012
24 RUE BETEILLE
12000 RODEZ
SIRET: 33332163600107 fermé
Fermé le 01/06/2012
153 RUE DE LA BARRE
46000 CAHORS
SIRET: 33332163600172 fermé
Fermé le 01/06/2012
66 AV DU PDT FRANKLIN ROOSEVELT
11000 CARCASSONNE
SIRET: 33332163600230 fermé
Fermé le 01/06/2012
23 RUE LAVOISIER
69680 CHASSIEU
SIRET: 33332163600263 fermé
Fermé le 01/06/2012
16 RUE DU CHALIBARDON ZAC ST FREDERIC
64100 BAYONNE
SIRET: 33332163600297 fermé
Fermé le 01/06/2012
ZAC DE SIAILLES RN 113
47240 CASTELCULIER
SIRET: 33332163600305 fermé
Fermé le 01/06/2012
PARASOL ZAC RTE DE FUMEL
47300 VILLENEUVE SUR LOT
SIRET: 33332163600362 fermé
Fermé le 01/06/2012
1 RUE FRANCIS MARCERO
11100 NARBONNE
SIRET: 33332163600370 fermé
Fermé le 01/06/2012
28 BD DE LA LIBERTE
34500 BEZIERS
SIRET: 33332163600388 fermé
Fermé le 01/06/2012
29 RUE ARMAND IZARN
66100 PERPIGNAN
SIRET: 33332163600412 fermé
Fermé le 01/06/2012
LES QUATRE ARBRES CENTRE D'ACTIVITE
78990 ELANCOURT
SIRET: 33332163600453 fermé
Fermé le 01/06/2012
RUE LOUIS BLERIOT
81150 MARSSAC-SUR-TARN
SIRET: 33332163600057 fermé
Fermé le 30/06/2010
RUE ANDRE AMPERE ZI DE JALARD
81000 ALBI
SIRET: 33332163600115 fermé
Fermé le 31/12/2009
76 FG LACAPELLE
82000 MONTAUBAN
SIRET: 33332163600206 fermé
Fermé le 31/12/2009
912 RUE DE BUGAREL
34070 MONTPELLIER
SIRET: 33332163600354 fermé
Fermé le 31/12/2009
28 RUE DE LA CALE
47200 MARMANDE
SIRET: 33332163600420 fermé
Fermé le 31/12/2009
PLAN DE CAMPAGNE LDT LA MEUNIERE
13480 CABRIES
SIRET: 33332163600313 fermé
Fermé le 30/06/2009
AV MARCEL PAUL
24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
SIRET: 33332163600396 fermé
Fermé le 30/06/2009
27 RUE FRANCOIS ARAGO
33700 MERIGNAC
SIRET: 33332163600404 fermé
Fermé le 30/06/2009
12 RUE RIVAROL
30000 NIMES
SIRET: 33332163600347 fermé
Fermé le 31/12/2008
ZI DE L ALBANNE
73490 LA RAVOIRE
SIRET: 33332163600271 fermé
Fermé le 31/05/2004
41 BD FRANCOIS MITTERRAND
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
SIRET: 33332163600222 fermé
Fermé le 31/12/2003
13 AV FEUCHERES
30000 NIMES
SIRET: 33332163600131 fermé
Fermé le 25/12/2003
12 RUE PAUL BERT
46100 FIGEAC
SIRET: 33332163600164 fermé
Fermé le 25/12/2003
RUE ANNE GACON ZA VGE ENTREPRISE ST HENRI
13016 MARSEILLE
SIRET: 33332163600248 fermé
Fermé le 31/12/2001
29 QUAI VICTOR HUGO
11100 NARBONNE
SIRET: 33332163600289 fermé
Fermé le 01/11/2001
25 RUE DE L'INDUSTRIE ZAC DE LA CROUZETTE
34500 BEZIERS
SIRET: 33332163600180 fermé
Fermé le 31/12/2000
17 RUE DE LA REPUBLIQUE
31800 SAINT-GAUDENS
SIRET: 33332163600198 fermé
Fermé le 25/12/1998
4 B BD MAL JOFFRE
11100 NARBONNE
SIRET: 33332163600214 fermé
Fermé le 25/12/1998
5 RUE ARNAVIELLE
30900 NIMES
SIRET: 33332163600149 fermé
Fermé le 01/01/1998
82 RTE DE BAYONNE
64140 BILLERE
SIRET: 33332163600156 fermé
Fermé le 01/01/1998
57 RUE BOILEAU
69006 LYON
SIRET: 33332163600123 fermé
Fermé le 30/06/1997
BD DE STRASBOURG RESIDENCE L'ECU
34000 MONTPELLIER
SIRET: 33332163600040 fermé
Fermé le 25/12/1995
442 AV JEAN MOULIN
82000 MONTAUBAN
SIRET: 33332163600065 fermé
Fermé le 25/12/1993
50 B RUE RAYNAL
12000 RODEZ

Dirigeants et représentants

3 Dirigeant(s) en exercice

SHIGENOBU NAGAO Directeur général délégué
TOMOTA YOICHI Président de SAS
SODECAL AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 314684481

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 21

Acquisition des copieurs multifonctions, mainte...
Marché Fournitures
Montant: 440 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 27/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOCATION ET MAINTENANCE DE 3 PHOTOCOPIEURS MULT...
Marché Fournitures
Acheteur: TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE Groupement de communes
Montant: 46 439,25€
Durée: 60 mois
Notification: 23/03/2026
Lieu d'exécution: 47000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Location et maintenance d’un parc de photocopie...
Marché Fournitures
Montant: 240 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 17/03/2026
Lieu d'exécution: 77250
Procédure: Procédure adaptée
LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS NUMERI...
Marché Services
Acheteur: COMMUNE DE CERET (MAIRIE) Commune
Montant: 180 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 12/03/2026
Lieu d'exécution: 66400
Procédure: Procédure adaptée
LOCATION ET MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTI...
Marché Fournitures
Montant: 235 362,88€
Durée: 50 mois
Notification: 12/03/2026
Lieu d'exécution: 84270
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOCATION ET MAINTENANCE COPIEURS ET IMPRIMANTES
Marché Fournitures
Montant: 84 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 04/03/2026
Lieu d'exécution: 34980
Procédure: Procédure adaptée
LOCATION MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS ET GARANTIE...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNE D'ORTHEZ (MAIRIE) Commune
Montant: 93 069,96€
Durée: 36 mois
Notification: 25/02/2026
Lieu d'exécution: 64300
Procédure: Procédure adaptée
Marché de fournitures et de services relatifsà...
Marché Fournitures
Montant: 41 235,24€
Durée: 36 mois
Notification: 16/02/2026
Lieu d'exécution: 45600
Procédure: Procédure adaptée
Location et maintenance de photocopieurs
Marché Fournitures
Montant: 63 585,20€
Durée: 36 mois
Notification: 12/02/2026
Lieu d'exécution: 73440
Procédure: Appel d'offres ouvert
Location et maintenance de photocopieurs
Marché Fournitures
Montant: 63 585,20€
Durée: 36 mois
Notification: 12/02/2026
Lieu d'exécution: 73440
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOCATION MAINTENANCE DE COPIEURS MULTIFONCTIONS
Marché Fournitures
Montant: 164 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 12/02/2026
Lieu d'exécution: 94510
Procédure: Procédure adaptée
Location-maintenance de copieurs multifonctions
Marché Fournitures
Montant: 200 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 12/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Location et maintenance d’une solution d’impres...
Marché Fournitures
Montant: 13 591,67€
Durée: 48 mois
Notification: 06/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
Acquisition, livraison installation et maintena...
Marché Fournitures
Montant: 4 519,30€
Durée: 60 mois
Notification: 04/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
LOCATION MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS
Marché Fournitures
Montant: 40 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 23/01/2026
Lieu d'exécution: 77140
Procédure: Procédure adaptée
Acquisition maintenance copieurs
Marché Fournitures
Montant: 215 000,00€
Durée: 120 mois
Notification: 21/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
2025I0118026-Maintenance et acquisition de phot...
Marché Fournitures
Acheteur: DEPARTEMENT DE L AVEYRON Département
Montant: 171 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 07/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Location maintenance de photocopieurs.
Marché Services
Montant: 220 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 06/01/2026
Lieu d'exécution: 95340
Procédure: Procédure adaptée
ACQUISITION MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR
Marché Fournitures
Montant: 89 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
FOURNITURE ET MAINTENANCE DE COPIEURS
Marché Services
Montant: 150 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution: 31776
Procédure: Procédure avec négociation
ACQUISITION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS
Marché Fournitures
Montant: 83 333,33€
Durée: 48 mois
Notification: 05/01/2026
Lieu d'exécution: 31776
Procédure: Procédure avec négociation

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
11/07/2025
N° 20250132-1718 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2025-03-31
BODACC B Modifications diverses
21/11/2024
N° 20240225-1078 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Avis initial
modification survenue sur l'administration - modification du Directeur général délégué Nomura, Seitaro ; nomination du Directeur général délégué : Shigenobu, Nagao
BODACC C Dépôts des comptes
11/07/2024
N° 20240133-4096 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
27/07/2023
N° 20230143-3046 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-03-31
BODACC B Modifications diverses
15/06/2023
N° 20230114-606 - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Avis initial
Modification de l'administration. - TOMOTA Yoichi nom d'usage : TOMOTA devient président. TUNG Yu Jen nom d'usage : TUNG n'est plus président
BODACC C Dépôts des comptes
20/10/2022
N° 20220204-3559 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-03-31
BODACC B Modifications diverses
16/10/2022
N° 20220201-929 - Haute-Garonne
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Avis initial
Modification de l'administration. - Société à responsabilité limitée SARL ALIZE AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CATHALA Jérôme n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SODECAL AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
BODACC C Dépôts des comptes
19/08/2021
N° 20210161-2281 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-03-31
BODACC B Modifications diverses
12/08/2021
N° 20210156-544 - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Modification de l'administration. - ASHIDA Jun nom d'usage : ASHIDA n'est plus président. TUNG Yu Jen nom d'usage : TUNG devient président
BODACC B Modifications diverses
01/10/2020
N° 20200191-1139 Toulouse (31100) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Nouveau siège.
BODACC C Dépôts des comptes
10/09/2020
N° 20200176-1405 Toulouse cedex 1 (31036) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-03-31
BODACC B Modifications diverses
12/03/2020
N° 20200051-1045 - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Modification de l'administration. - HUMBERT Bruno nom d'usage : HUMBERT n'est plus directeur général
BODACC C Dépôts des comptes
14/11/2019
N° 20190219-811 Toulouse cedex 1 (31036) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-03-31
BODACC B Modifications diverses
23/12/2018
N° 20180245-315 - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Modification de l'administration. - DARIOS Michel nom d'usage : DARIOS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CATHALA Jérôme devient commissaire aux comptes suppléant
BODACC C Dépôts des comptes
20/12/2018
N° 20180238-3872 Toulouse cedex 1 (31036) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-03-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/12/2017
N° 20170127-3348 Toulouse cedex 1 (31036) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-03-31
BODACC B Modifications diverses
15/12/2017
N° 20170241-1429 - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Modification de l'administration. - KAWAMURA Tetsuji nom d'usage : KAWAMURA n'est plus président. ASHIDA Jun nom d'usage : ASHIDA devient président. ITO Hironobu nom d'usage : ITO n'est plus directeur général délégué. NOMURA Seitari nom d'usage : NOMURA devient directeur général délégué
BODACC A Ventes et cessions
03/05/2017
N° 20170085-1481 Toulouse, Roissy Ch-de-Gaulle Cedex (31036, 95948) - Seine-Saint-Denis
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Avis initial
- Acte SSP en date du 31/03/2017 enregistré au service départemental de l'enregistrement de BOBIGNY le 21/04/2017 Dossier 2017 12133, référence 2017 A 05999. Précédent propriétaire : Sharp Electronics France SA (RCS BOBIGNY 722 004 694) dont le siège social est sis 22, avenue des Nations, ZAC Paris Nord 2, BP 52094 Villepinte, 95948 Roissy Charles de Gaulle Cedex. - Début d'activité: 2017-04-01
BODACC C Dépôts des comptes
09/11/2016
N° 20160119-815 Toulouse cedex 1 (31036) - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-03-31
BODACC B Modifications diverses
08/11/2016
N° 20160218-845 - Haute-Garonne
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Avis initial
Modification de l'administration. - RAYNAUD Axel Bertrand nom d'usage : RAYNAUD n'est plus directeur général délégué