Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 21/04/2026

SOLUTEC

En activité
SIREN 381 345 941

Adresse 10 RUE JOANNES CARRET 69009 LYON 9E ARRONDISSEMENT

Activité Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 02/04/1991

Dirigé par
COLIN FRANCK , INVERNIZZI NICOLAS , DEBRUN VERCHERE CONSEILS , AUBAY

Activité

Code APE/NAF
6202A
Libellé d'activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Objet
Conseil en systèmes et logiciels informatiques, vente de services aux entreprises, études, ingénierie, assistance technique
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 38134594100185 Siège ouvert
10 RUE JOANNES CARRET
69009 LYON 9E ARRONDISSEMENT
SIRET: 38134594100169 ouvert
8 ESP COMPANS CAFFARELLI IMMEUBLE ATRIA
31000 TOULOUSE
SIRET: 38134594100193 ouvert
55 RUE DE LUXEMBOURG
59800 LILLE
SIRET: 38134594100201 ouvert
1 B PL DE LA DEFENSE
92400 COURBEVOIE
SIRET: 38134594100219 ouvert
5 BD VINCENT GÂCHE
44200 NANTES
SIRET: 38134594100227 ouvert
38 RUE DES MARAÎCHERS
33800 BORDEAUX
SIRET: 38134594100144 fermé
Fermé le 01/04/2026
32 ALL DE BOUTAUT PLACE RAVEZIES CS80112
33300 BORDEAUX
SIRET: 38134594100177 fermé
Fermé le 26/01/2026
9 BD DE BERLIN SPACE EURONANTES
44000 NANTES
SIRET: 38134594100128 fermé
Fermé le 19/12/2024
86 BD HAUSSMANN 86-88
75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT
SIRET: 38134594100151 fermé
Fermé le 28/10/2024
63 AV GALLINE
69100 VILLEURBANNE
SIRET: 38134594100110 fermé
Fermé le 16/10/2023
22 MAIL PABLO PICASSO
44000 NANTES
SIRET: 38134594100102 fermé
Fermé le 27/08/2018
50 QUAI PAUL SEDALLIAN
69009 LYON
SIRET: 38134594100136 fermé
Fermé le 31/05/2018
20 RUE DE LA VILLETTE IMMEUBLE LE BONNEL
69003 LYON
SIRET: 38134594100094 fermé
Fermé le 31/05/2016
4 RUE DE VENTADOUR
75001 PARIS
SIRET: 38134594100078 fermé
Fermé le 26/10/2012
12 RUE CLAUDE CHAPPE PARC D'AFFAIRES DE CRECY
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
SIRET: 38134594100060 fermé
Fermé le 31/12/2011
RUE MARCELIN BERTHELOT LE MERCURE C
13290 AIX-EN-PROVENCE
SIRET: 38134594100086 fermé
Fermé le 31/12/2010
6 B AV LEDRU-ROLLIN 6 BIS A 10
75012 PARIS
SIRET: 38134594100052 fermé
Fermé le 14/03/2008
207 RUE DE BERCY TOUR MATTEI
75012 PARIS
SIRET: 38134594100011 fermé
Fermé le 09/08/2007
CHE FERRAND TELEBASE LYON
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
SIRET: 38134594100045 fermé
Fermé le 01/07/2000
14 RES PARC CLUB DU GOLF ESPACE CEZANNE
13080 AIX EN PROVENCE
SIRET: 38134594100037 fermé
Fermé le 30/06/1999
27 RUE RAFFET 27-29
75016 PARIS
SIRET: 38134594100029 fermé
Fermé le 31/12/1996
7 RUE DE BUCAREST
75008 PARIS

Dirigeants et représentants

4 Dirigeant(s) en exercice

COLIN FRANCK Commissaire aux comptes suppléant
INVERNIZZI NICOLAS Directeur Général
DEBRUN VERCHERE CONSEILS Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 353860851
AUBAY Président de SAS
 SIREN: 391504693

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 12

Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint
Système d’acquisition dynamique relatif aux pre...
Marché Services
Montant: 0,20€
Durée: 79 mois
Notification: 20/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres restreint

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
17/07/2025
N° 20250135-8559 Lyon (69009) - Rhône
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC B Modifications diverses
15/07/2025
N° 20250134-4175 - Rhône
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Avis initial
Modification de l'administration. - Union d'économie sociale en SA AUBAY devient président. Sté par actions simplifiée HOLDING SOLUTEC n'est plus président
BODACC B Modifications diverses
15/12/2024
N° 20240242-1643 - Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Avis initial
Modification de l'administration. - Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire GOOD MORNING Société à responsabilité limitée
BODACC C Dépôts des comptes
07/11/2024
N° 20240216-7632 Lyon (69009) - Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC B Modifications diverses
24/10/2024
N° 20240207-2372 Lyon (69009) - Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Avis initial
Modification de l'administration. Nouveau siège. - Sté par actions simplifiée HOLDING SOLUTEC devient président. BRUYERE Jean nom d'usage : BRUYERE n'est plus président
BODACC C Dépôts des comptes
03/08/2023
N° 20230148-10203 Villeurbanne (69100) - Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
30/06/2022
N° 20220126-9488 Villeurbanne (69100) - Rhône
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
24/06/2021
N° 20210122-5961 Villeurbanne (69100) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
06/08/2020
N° 20200151-12009 Villeurbanne (69100) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
04/07/2019
N° 20190127-10169 Villeurbanne (69100) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/09/2018
N° 20180184-2938 Villeurbanne (69100) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Nouveau siège.
BODACC C Dépôts des comptes
09/08/2018
N° 20180145-11667 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
26/08/2017
N° 20170086-885 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
10/08/2016
N° 20160079-9050 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC B Modifications diverses
08/03/2016
N° 20160047-1900 - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Modification de l'administration. - INVERNIZZI Nicolas nom d'usage : INVERNIZZI devient directeur général.
BODACC B Modifications diverses
12/08/2015
N° 20150153-2504 - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Modification de l'administration. - DEBRUN BERNARD nom d'usage : DEBRUN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. COLIN Franck nom d'usage : COLIN devient commissaire aux comptes suppléant.
BODACC C Dépôts des comptes
10/08/2015
N° 20150074-4629 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
11/08/2014
N° 20140053-6292 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/07/2013
N° 20130045-10802 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2012-12-31
BODACC B Modifications diverses
05/12/2012
N° 20120235-2524 Lyon (69009) - Rhône
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Avis initial
Nouveau siège. Modification de l'activité.