Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 02/04/2026

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

En activité
SIREN 479 766 842

Adresse 145-151 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 92130 Issy-les-Moulineaux

Activité Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 07/12/2004

Dirigé par
SIMEON JEROME , BENOIST EMMANUEL , FERRARIS PATRICK , BOUEE PIERRE-OLIVIER MARIE GEORGES , FORVIS MAZARS SA , PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Activité

Code APE/NAF
6202A
Libellé d'activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Objet
Les activités d'études et de conseil en matière de systèmes informatiques.
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 47976684200724 Siège ouvert
145-151 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
92130 Issy-les-Moulineaux
SIRET: 47976684200088 ouvert
12 RUE EMILE ZOLA
45000 ORLEANS
SIRET: 47976684200112 ouvert
ALL JAMES WATT BP 60153
33700 MERIGNAC
SIRET: 47976684200138 ouvert
16 MAIL PABLO PICASSO
44000 NANTES
SIRET: 47976684200187 ouvert
5 RUE JOSEPH SZYDLOWSKI BATIMENT ASTRIA
64100 BAYONNE
SIRET: 47976684200203 ouvert
10 QUAI COMMANDANT MALBERT
29200 BREST
SIRET: 47976684200237 ouvert
120 IMP JEAN BAPTISTE SAY CONCORDE BT A-PARC ACTIV. AEROPORT
34470 PEROLS
SIRET: 47976684200260 ouvert
17 RUE DE LA HAYE ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE
67300 SCHILTIGHEIM
SIRET: 47976684200344 ouvert
7 RUE CLAUDE CHAPPE LES CHAMPS BLANCS
35510 CESSON-SEVIGNE
SIRET: 47976684200351 ouvert
400 AV ROUMANILLE SOPHIA ANTIPOLIS
06410 BIOT
SIRET: 47976684200369 ouvert
109 AV DU GENERAL EISENHOWER DIVISION AEROSPATIALE ET DEFENSE
31100 TOULOUSE
SIRET: 47976684200377 ouvert
2 RUE DU CARDINAL TISSERANT 2 AU 4
54000 NANCY
SIRET: 47976684200385 ouvert
95 CHE DE L'ETOILE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
SIRET: 47976684200393 ouvert
17 AV DE LA GARE
07120 RUOMS
SIRET: 47976684200419 ouvert
4 RUE JULES FERRY IMMEUBLE NEWTON - 2EME ETAGE
64000 PAU
SIRET: 47976684200435 ouvert
1 AVENUE DE LA GARE TVG
90400 MEROUX-MOVAL
SIRET: 47976684200468 ouvert
30 RUE CLAUDE CHAPPE CHEZ XEROX
07500 GUILHERAND-GRANGES
SIRET: 47976684200476 ouvert
43 RUE PRE GAUDRY IMMEUBLE IVOIRE
69007 LYON 7E ARRONDISSEMENT
SIRET: 47976684200484 ouvert
6 RUE NATHALIE LEMEL
44000 NANTES
SIRET: 47976684200500 ouvert
350 AV J.R. GUILBERT DE LA LAUZIERE Bâtiment Azur N.17 PARC CLUB DU GOLF
13100 Aix-en-Provence
SIRET: 47976684200518 ouvert
7 AV MARIE-LOUISE DELWAULLE LILLE LOMME
59160 LILLE
SIRET: 47976684200542 ouvert
23 AV DE TOURVILLE BATIMENT A & B - EQUEURDREVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
SIRET: 47976684200559 ouvert
1 RUE DE COURTONNE
14000 CAEN
SIRET: 47976684200609 ouvert
9 RUE DE SAINT AMARIN PROLONGEE
68100 MULHOUSE
SIRET: 47976684200641 ouvert
13 RUE DE COPENHAGUE
67300 SCHILTIGHEIM
SIRET: 47976684200674 ouvert
RTE D'AVIGNON ZONE ARTISANALE RUE DE L'EUZE NATIONAL
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
SIRET: 47976684200682 ouvert
PL BRUAT BASE NAVALE CHERBOURG OCTEVILLE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
SIRET: 47976684200690 ouvert
100 RUE DES VINDITS
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
SIRET: 47976684200708 ouvert
RTE DE NOZAY
91460 MARCOUSSIS
SIRET: 47976684200716 ouvert
8 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD IMMEUBLE LE COLOMBIA
31100 TOULOUSE
SIRET: 47976684200740 ouvert
69 RUE DES MARAIS
79000 NIORT
SIRET: 47976684200773 ouvert
38 T RUE DE RENNES HUBLAIS 2
35510 CESSON-SEVIGNE
SIRET: 47976684200799 ouvert
120 RUE FRANCOIS JACOB
76230 ISNEAUVILLE
SIRET: 47976684200815 ouvert
200 BD DE LA RESISTANCE
71000 MACON
SIRET: 47976684200823 ouvert
19 RUE DE PROVENCE
75009 PARIS
SIRET: 47976684200849 ouvert
5 AV ALBERT DURAND AEROPOLE
31700 BLAGNAC
SIRET: 47976684200856 ouvert
12 RUE DE LA VERRERIE
92190 MEUDON
SIRET: 47976684200864 ouvert
33 RUE FABIENNE LANDY ILOT 4-ZAC DE LA GARE
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
SIRET: 47976684200880 ouvert
217 RUE HAROUN TAZIEFF ECOPARC OCEANIS 4B -
54320 MAXEVILLE
SIRET: 47976684200898 ouvert
BD SOLIDARITE IMMEUBLE FIRST PLAZA QUARTIER B
57070 METZ
SIRET: 47976684200906 ouvert
355 AV ALEXIS DE ROCHON
29280 PLOUZANE
SIRET: 47976684200922 ouvert
15 RUE DES METIERS
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
SIRET: 47976684200930 ouvert
3 RUE LOUIS BRAILLE BATIMENT EOLIOS ZAC DE LA COUR
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
SIRET: 47976684200948 ouvert
4 AV DIDIER DAURAT IMMEUBLE CENTREDA 1 ET 3
31700 BLAGNAC
SIRET: 47976684200955 ouvert
43 RUE ELSA TRIOLET PARC TERTIAIRE VALMY
21000 DIJON
SIRET: 47976684200963 ouvert
AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE LES CARRES DU GOLF BATIMENT B
13080 AIX-EN-PROVENCE
SIRET: 47976684200971 ouvert
BD SEBASTIEN BRANT IMMEUBLE GAUSSE
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
SIRET: 47976684201003 ouvert
1 IMP CHARLES TRENET
44800 SAINT-HERBLAIN
SIRET: 47976684201011 ouvert
19 BD MER CASPIENNE
73370 LE BOURGET-DU-LAC
SIRET: 47976684201029 ouvert
145 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 145-151- BATIMENT B-EXP
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 47976684201037 ouvert
1375 RTE DES DOLINES 30 ALLEE PIERRE ZILLER
06560 VALBONNE
SIRET: 47976684201045 ouvert
5 RUE BELLINI 5-7
92800 PUTEAUX
SIRET: 47976684201052 ouvert
3 RUE TARFAYA
31400 TOULOUSE
SIRET: 47976684201060 ouvert
2 RUE MARCEAU 2-10
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 47976684201078 ouvert
26 RUE MARCEAU
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 47976684201086 ouvert
99 CHE DE L’ETOILE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
SIRET: 47976684201094 ouvert
RUE CAMBACERES MYRIAM MIRZAKHANI IMMEUBLELOT E34
34000 MONTPELLIER
SIRET: 47976684201110 ouvert
34 RUE du Clos Four
63100 Clermont-Ferrand
SIRET: 47976684200195 fermé
Fermé le 31/03/2026
9 ALL ALAN TURING PARC TECHNOLOGIQUE LE PARDIEU
63170 AUBIERE
SIRET: 47976684200625 fermé
Fermé le 28/02/2025
8 RUE PAUL MESPLE IMMEUBLE COURONNE
31100 TOULOUSE
SIRET: 47976684200732 fermé
Fermé le 18/12/2024
2 RUE MAURICE MALLET
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 47976684200872 fermé
Fermé le 31/03/2024
950 AV ROUMANILLE BATIMENT TECK -
06410 BIOT
SIRET: 47976684200583 fermé
Fermé le 31/12/2023
187 AV DU HAUT LEVEQUE 3 RUE MARCEL DASSAULT
33600 PESSAC
SIRET: 47976684200567 fermé
Fermé le 30/06/2023
SAVOIE TECHNOLAC BATIMENT TRIPLAN
73370 LE BOURGET-DU-LAC
SIRET: 47976684200989 fermé
Fermé le 01/05/2023
2656 AV GEORGES FRECHE ZAC DE L AEROPORT
34470 PEROLS
SIRET: 47976684200914 fermé
Fermé le 28/03/2023
1 RUE DES TROPIQUES 1 3 CASSIOPEE B
38130 ECHIROLLES
SIRET: 47976684200831 fermé
Fermé le 28/02/2023
2 AV DES SAULES
59160 LILLE
SIRET: 47976684200997 fermé
Fermé le 31/01/2023
110 AV DE FLANDRE
59290 WASQUEHAL
SIRET: 47976684200450 fermé
Fermé le 01/01/2023
17 QUAI JOSEPH GILLET
69004 LYON
SIRET: 47976684200427 fermé
Fermé le 01/05/2022
1 PL DES FRERES MONTGOLFIER GUYANCOURT
78280 GUYANCOURT
SIRET: 47976684200211 fermé
Fermé le 31/12/2021
4 B RUE EMILE ZOLA
37000 TOURS
SIRET: 47976684200526 fermé
Fermé le 31/12/2021
26 AV DES LILAS
64000 PAU
SIRET: 47976684200617 fermé
Fermé le 30/09/2021
BD HENRI ZIEGLER LE GALILEE BAT.A - ZAC ANDROMEDE
31700 BLAGNAC
SIRET: 47976684200591 fermé
Fermé le 31/03/2021
31 RUE THOMAS EDISON
33610 CANEJAN
SIRET: 47976684200492 fermé
Fermé le 18/01/2021
160 AV JEAN JAURES 160-162
69007 LYON
SIRET: 47976684200765 fermé
Fermé le 30/09/2020
8 RUE GRANGE DAME ROSE
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
SIRET: 47976684200401 fermé
Fermé le 30/06/2020
72 RUE DE LA REPUBLIQUE
76140 LE PETIT-QUEVILLY
SIRET: 47976684200658 fermé
Fermé le 31/05/2020
3 B BELLE FONTAINE IMMEUBLE LE NEWTON
35510 CESSON-SEVIGNE
SIRET: 47976684200807 fermé
Fermé le 31/03/2020
4 RUE PIERRE GILLES DE GENNES PARC DE LA VATINE
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
SIRET: 47976684200781 fermé
Fermé le 24/01/2020
AV DU GOLF PARC D'ACTIVITES L'OREE DES MAS
34670 BAILLARGUES
SIRET: 47976684200286 fermé
Fermé le 30/06/2019
5 RUE FREDERIC CLAVEL 5-7
92150 SURESNES
SIRET: 47976684200310 fermé
Fermé le 30/06/2019
55 QUAI MARCEL DASSAULT
92210 SAINT-CLOUD
SIRET: 47976684200443 fermé
Fermé le 30/06/2019
24 RUE DU GOUVERNEUR GENERAL EBOUE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 47976684200534 fermé
Fermé le 30/06/2019
18 AV LEO LAGRANGE
79000 NIORT
SIRET: 47976684200575 fermé
Fermé le 30/06/2019
6 RUE DE L'ETANG TECHN'HOM 1
90000 BELFORT
SIRET: 47976684200633 fermé
Fermé le 31/05/2019
97 RUE DE FREYR
34000 MONTPELLIER
SIRET: 47976684200757 fermé
Fermé le 01/02/2019
147 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT IMMEUBLE AQUAREL
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIRET: 47976684200666 fermé
Fermé le 01/11/2018
SAVOIE TECHNOLAC BATIMENT TRIPLAN
73370 LE BOURGET-DU-LAC
SIRET: 47976684200047 fermé
Fermé le 31/10/2018
AV DE BRETAGNE
59000 LILLE
SIRET: 47976684200336 fermé
Fermé le 14/02/2018
2 RUE CAZEMAJOU L'ANGLE -
13015 MARSEILLE
SIRET: 47976684200062 fermé
Fermé le 30/11/2017
2 RUE JEAN PERRIN INNOVAPARC BATIMENT D
14460 COLOMBELLES
SIRET: 47976684200229 fermé
Fermé le 01/03/2017
523 CRS DU TROISIEME MILLENAIRE PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON - PARC MAIL
69800 SAINT-PRIEST
SIRET: 47976684200153 fermé
Fermé le 30/09/2016
193 RUE DE BERCY TOUR GAMMA A
75012 PARIS
SIRET: 47976684200278 fermé
Fermé le 19/04/2015
2 AV DU PRESIDENT PIERRE ANGOT CENTRE HELIOPART
64000 PAU
SIRET: 47976684200054 fermé
Fermé le 05/05/2014
20 AV ANDRE PROTHIN TOUR EUROPLAZA
92400 COURBEVOIE
SIRET: 47976684200070 fermé
Fermé le 31/12/2013
15 AV DU DOCTEUR MAURICE GRYNFOGEL
31100 TOULOUSE
SIRET: 47976684200120 fermé
Fermé le 31/12/2013
485 AV DE L’EUROPE
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
SIRET: 47976684200302 fermé
Fermé le 31/12/2013
37 RUE DE LYON
75012 PARIS
SIRET: 47976684200161 fermé
Fermé le 01/12/2013
70 RUE PIERRE CORNEILLE
76140 LE PETIT-QUEVILLY
SIRET: 47976684200328 fermé
Fermé le 01/12/2013
5 RUE DU PETIT BOIS
07120 RUOMS
SIRET: 47976684200096 fermé
Fermé le 31/10/2013
101 AV DE LA LIBERATION CENTRE D'AFFAIRES LIBERATION BP 20677
54000 NANCY
SIRET: 47976684200146 fermé
Fermé le 14/06/2013
455 PRO DES ANGLAIS PORTE DE L'ARENAS ENTREE B
06000 NICE
SIRET: 47976684200245 fermé
Fermé le 19/12/2012
3 ALL DE LA CROIX DES HETRES
35000 RENNES
SIRET: 47976684200252 fermé
Fermé le 19/12/2012
5 ALL DE LA CROIX DES HETRES
35000 RENNES
SIRET: 47976684200294 fermé
Fermé le 19/12/2012
RUE FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR PARC OBERTHUR - 74D
35000 RENNES
SIRET: 47976684200104 fermé
Fermé le 31/03/2012
2 ALL DES GEMEAUX CENTRE NOVAXIS
72000 LE MANS
SIRET: 47976684200179 fermé
Fermé le 30/03/2011
90 CHE DU ROY D'ESPAGNE BP 23
13009 MARSEILLE
SIRET: 47976684200013 fermé
Fermé le 16/02/2010
110 ESP DU GENERAL DE GAULLE COEUR DEFENSE TOUR A
92400 COURBEVOIE
SIRET: 47976684200021 fermé
Fermé le 01/06/2009
181 RUE JULES DELCENSERIE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
SIRET: 47976684200039 fermé
Fermé le 30/11/2008
45 RUE DES TROIS SOEURS
93420 VILLEPINTE

Dirigeants et représentants

6 Dirigeant(s) en exercice

SIMEON JEROME Président de SAS
BENOIST EMMANUEL Commissaire aux comptes suppléant
FERRARIS PATRICK Directeur Général
BOUEE PIERRE-OLIVIER MARIE GEORGES Directeur Général
FORVIS MAZARS SA Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 784824153
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 672006483

Comptes annuels 10

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 8

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploie...
Marché Services
Acheteur: DEPARTEMENT DE L ISERE Département
Montant: 2 800 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 08/04/2026
Lieu d'exécution: 38000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 2 Applicatif Business Intelligence - App...
Marché Services
Montant: 4 000 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 17/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OEUVRE INFORMATIQUE
Marché Services
Montant: 1 000 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 17/03/2026
Lieu d'exécution: 33081
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 1 Applicatif Web
Marché Services
Montant: 4 000 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 09/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
SECURITE DES SYSTEMES D INFORMATION
Marché Fournitures
Montant: 150 000 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 05/03/2026
Lieu d'exécution: 91800
Procédure: Appel d'offres ouvert
RESAH La centrale d’achats
Marché Fournitures
Montant: 400 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 16/02/2026
Lieu d'exécution: 11000
Procédure: Appel d'offres ouvert
Réalisation de prestations de tierce maintenanc...
Marché Services
Montant: 1 500 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 28/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Fourniture de prestations informatiques de réal...
Marché Services
Montant: 7 500 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 15/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC A Ventes et cessions
05/08/2025
N° 20250148-3289 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF Capgemini Engineering Research and Development Société par actions simplifiée Au capital de : 15 246 305,32 EUR Siège social 145-151 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux N° RCS 444 495 774 RCS Nanterre, est société bénéficiaire CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES Société par actions simplifiée Au capital de : 7 296 894,00 EUR Siège social 145-151 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux N° RCS 479 766 842 RCS Nanterre, est société apporteuse Montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire : 1 521 581,66 EUROS Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : Actif apporté : 34 675 996,69 EUROS Passif pris en charge : 22 536 887,77 EUROS Actif net apporté : 12 139 108,92 EUROS Montant prévu de la prime d’apport : 10 617 527,26 EUROS Date du projet d’apport : 30/07/2025 Date et lieu du dépôt du projet d’apport au greffe du tribunal pour chacune des sociétés participant à l’opération 31/07/2025 au TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE pour la bénéficiaire 31/07/2025 au TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE pour l’apporteuse
BODACC C Dépôts des comptes
02/06/2025
N° 20250105-9854 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC B Modifications diverses
22/05/2025
N° 20250098-2862 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SIMEON Jérôme ; Directeur général : FERRARIS Patrick ; Directeur général : BOUEE Pierre-Olivier Marie Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Emmanuel
BODACC B Modifications diverses
07/03/2025
N° 20250047-2013 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SIMEON Jérôme ; Directeur général : FERRARIS Patrick ; Directeur général : BOUEE Pierre-Olivier Marie Georges ; Directeur général : PFEIL Oliver, Gunther ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Emmanuel
BODACC A Ventes et cessions
21/11/2024
N° 20240225-2049 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES Société par actions simplifiée Au capital de : 7 296 894,00 EUR Siège social 145-151 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux N° RCS 479 766 842 RCS Nanterre, est société absorbante KNOWLEDGE EXPERT Société par actions simplifiée Au capital de : 10 000,00 EUR Siège social 145-151 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux N° RCS 841 323 736 RCS Nanterre, est société absorbée 2°) Montant de l’augmentation de capital de la société absorbante : NEANT 3°) Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : ACTIF :1 836 096 EUROS PASSIF TRANSMIS :494 565 EUROS ACTIF NET APPORTÉ :1 341 531 EUROS 4°) Rapport d’échange des droits sociaux : NEANT 5°) Montant prévu de la prime de fusion : NEANT Date du projet : 18/11/2024 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 18/11/2024, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société KNOWLEDGE EXPERT et au nom de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
BODACC B Modifications diverses
18/09/2024
N° 20240181-2326 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration.
BODACC C Dépôts des comptes
23/05/2024
N° 20240098-7767 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
26/05/2023
N° 20230101-3943 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC B Modifications diverses
24/02/2023
N° 20230039-19115 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SIMEON Jérôme ; Directeur général : HOCHET Xavier ; Directeur général : FERRARIS Patrick ; Directeur général : BOUEE Pierre-Olivier Marie Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Emmanuel
BODACC B Modifications diverses
02/08/2022
N° 20220148-2796 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SIMEON Jérôme ; Directeur général : HOCHET Xavier ; Directeur général : BONNARD Christophe ; Directeur général : FERRARIS Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : BENOIST Emmanuel
BODACC B Modifications diverses
10/05/2022
N° 20220091-3616 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur le capital.
BODACC C Dépôts des comptes
06/05/2022
N° 20220089-2815 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
29/04/2021
N° 20210084-9096 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC B Modifications diverses
29/04/2021
N° 20210084-3786 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur le capital.
BODACC B Modifications diverses
10/01/2021
N° 20210006-2198 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SIMEON Jérôme ; Directeur général : HOCHET Xavier ; Directeur général : BONNARD Christophe ; Directeur général : FERRARIS Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe
BODACC C Dépôts des comptes
07/01/2021
N° 20210004-3364 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
11/06/2020
N° 20200112-2946 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : SIMEON Jérôme ; Directeur général : HOCHET Xavier ; Directeur général : CHINAL Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe
BODACC C Dépôts des comptes
09/06/2020
N° 20200110-3101 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/05/2020
N° 20200101-1130 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur le capital.
BODACC B Modifications diverses
20/02/2020
N° 20200036-3877 Issy-les-Moulineaux (92130) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur le capital.