Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 12/01/2026

THERMATIC

En activité
SIREN 426 980 033

Adresse 16 RUE NICEPHORE NIEPCE ZAE MALAN LE GAZET 4 12510 OLEMPS

Activité Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 29/01/1969

Dirigé par
BLANC GUILLAUME TONY MICHEL , Groupe Climater , DRB AUDIT

Activité

Code APE/NAF
4322B
Libellé d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Objet
Installateur de chauffage central
Date de clôture d'exercice
30/06

Établissements de l'entreprise

SIRET: 42698003300085 Siège ouvert
16 RUE NICEPHORE NIEPCE ZAE MALAN LE GAZET 4
12510 OLEMPS
SIRET: 42698003300077 ouvert
16 RUE SAINT EXUPERY LA LAUZE
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
SIRET: 42698003300010 fermé
Fermé le 06/04/2021
RUE DE LA PRADE ZONE INDUSTRIELLE
12850 ONET-LE-CHATEAU
SIRET: 42698003300051 fermé
Fermé le 31/12/2010
42 BD DE LA PADOUANE ZA DITE ARTIZANORD
13015 MARSEILLE
SIRET: 42698003300069 fermé
Fermé le 01/12/2000
PARC MARCEL DASSAULT DEVES EXPANSION
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Dirigeants et représentants

3 Dirigeant(s) en exercice

BLANC GUILLAUME TONY MICHEL Directeur Général
Groupe Climater Président de SAS
 SIREN: 834423774
DRB AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 810861021

Comptes annuels 10

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 8

CONSTRUCTION D¿UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNE DE JACOU (MAIRIE) Commune
Montant: 11 021 122,32€
Durée: 56 mois
Notification: 21/04/2026
Lieu d'exécution: 34830
Procédure: Procédure adaptée
CHAUFFAGE CLIMATISATION HOTEL AGGLO
Marché Fournitures
Acheteur: RODEZ AGGLOMERATION Groupement de communes
Montant: 1 061 969,29€
Durée: 16 mois
Notification: 12/03/2026
Lieu d'exécution: 12035
Procédure: Procédure adaptée
Relance des Lots 11 et 14 - Travaux de restruct...
Marché Travaux
Acheteur: COMMUNE DE SETE (MAIRIE) Commune
Montant: 988 932,94€
Durée: 16 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 34200
Procédure: Procédure adaptée
Construction crèche Mireille LAGET - Chauffage...
Marché Travaux
Montant: 12 926,61€
Durée: 18 mois
Notification: 26/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
CONSTRUCTION CRECHE MIREILLE LAGET LOT 10 - CHA...
Marché Travaux
Montant: 511 925,00€
Durée: 18 mois
Notification: 26/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Procédure adaptée
2025B015617-Restructuration du Palais Episcopal...
Marché Travaux
Acheteur: DEPARTEMENT DE L AVEYRON Département
Montant: 1 346 912,00€
Durée: 22 mois
Notification: 09/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
L11 - CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION
Marché Fournitures
Acheteur: RODEZ AGGLOMERATION Groupement de communes
Montant: 110 664,36€
Durée: 14 mois
Notification: 03/02/2026
Lieu d'exécution: 12035
Procédure: Procédure adaptée
Réaménagement de la médiathèque de Rodez - Lot...
Marché Fournitures
Acheteur: COMMUNE DE RODEZ (MAIRIE) Commune
Montant: 66 216,00€
Durée: 7 mois
Notification: 26/01/2026
Lieu d'exécution: 12000
Procédure: Procédure adaptée

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
28/12/2025
N° 20250249-702 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2025-06-30
BODACC C Dépôts des comptes
29/01/2025
N° 20250020-474 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-06-30
BODACC C Dépôts des comptes
14/02/2024
N° 20240031-291 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-06-30
BODACC B Modifications diverses
04/01/2023
N° 20230002-233 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : Groupe Climater ; Directeur général : BLANC Guillaume, Tony, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : DRB AUDIT
BODACC C Dépôts des comptes
31/12/2022
N° 20220255-597 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-06-30
BODACC B Modifications diverses
13/04/2022
N° 20220073-341 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : Groupe Climater ; Directeur général : BLANC Guillaume, Tony, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : ALBOUY ASSOCIES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL GEC CONSEIL
BODACC C Dépôts des comptes
13/04/2022
N° 20220073-361 Olemps (12510) - Aveyron
Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-06-30
BODACC C Dépôts des comptes
21/07/2021
N° 20210140-576 Olemps (12510) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC B Modifications diverses
30/06/2021
N° 20210126-227 Olemps (12510) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
transfert du siège social.
BODACC B Modifications diverses
30/06/2021
N° 20210126-228 Olemps (12510) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : Groupe Climater ; Commissaire aux comptes titulaire : ALBOUY ASSOCIES AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL GEC CONSEIL
BODACC C Dépôts des comptes
24/07/2020
N° 20200142-885 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
09/07/2019
N° 20190130-1328 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2018-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
27/07/2018
N° 20180136-751 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2017-12-31
BODACC B Modifications diverses
20/08/2017
N° 20170158-185 - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration - Président : BOUTONNET Sébastien, Nicolas, Eric ; Directeur général : FALIP Yannick, Josian, Raoul ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
BODACC B Modifications diverses
20/08/2017
N° 20170158-196 - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président : BOUTONNET Sébastien, Nicolas, Eric ; Directeur général : FALIP Yannick, Josian, Raoul ; Commissaire aux comptes titulaire : ALBOUY ASSOCIES AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL GEC CONSEIL (SARL)
BODACC C Dépôts des comptes
04/08/2017
N° 20170071-587 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2016-12-31
BODACC B Modifications diverses
27/01/2017
N° 20170019-100 - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Modification survenue sur l'administration - Président du conseil d'administration, Administrateur : BOUTONNET Sébastien, Nicolas, Eric ; Directeur général, Administrateur : LEDUC Serge, Francis ; Directeur général délégué, Administrateur : FALIP Yannick, Josian, Raoul ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
BODACC C Dépôts des comptes
22/08/2016
N° 20160085-392 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2015-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
26/08/2015
N° 20150084-636 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2014-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
01/09/2014
N° 20140062-982 Onet-le-Château (12850) - Aveyron
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2013-12-31