Source: Inpi / Insee | Dernière mise à jour Inpi : 20/01/2026

WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

En activité
SIREN 311 248 637

Adresse 52 AV DU GENERAL DE GAULLE TOUR HEKLA 92800 PUTEAUX

Activité Activités des agents et courtiers d'assurances

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

Création 17/10/1977

Dirigé par
PULLUM ANNE BRENNAN , DUSSUYER NICOLAS DIDIER JOHANNES , DELOITTE & ASSOCIES

Activité

Code APE/NAF
6622Z
Libellé d'activité
Activités des agents et courtiers d'assurances
Objet
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : -le courtage d'assurances et de réassurances, toutes opérations relatives à cet objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation, ainsi que toutes activités similaires et connexes, -toutes opérations de courtage en opérations de banque et en services de paiement ainsi que l'activité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement.
Date de clôture d'exercice
31/12

Établissements de l'entreprise

SIRET: 31124863701208 Siège ouvert
52 AV DU GENERAL DE GAULLE TOUR HEKLA
92800 PUTEAUX
SIRET: 31124863700390 ouvert
2 RUE DE GOURVILLE
45140 ORMES
SIRET: 31124863700440 ouvert
LA TROMPEUSE IM SYNERGIE
97232 LE LAMENTIN
SIRET: 31124863700473 ouvert
9 BD LIEUTENANT MAURICE KNOBLAUCH
42100 SAINT-ETIENNE
SIRET: 31124863700630 ouvert
1 AV EUGENE FREYSSINET IMMEUBLE CHALLENGER
78280 GUYANCOURT
SIRET: 31124863700788 ouvert
5 RUE ANDRE LARDY CENTRE D'AFF. LA MARE BAT LA TURBINE
97438 SAINTE-MARIE
SIRET: 31124863700796 ouvert
5 AV RAYMOND MANAUD
33520 BRUGES
SIRET: 31124863700838 ouvert
LA PARDIEU ZAC DES SAUZES - PARC TECHNOLOGIQUE
63000 CLERMONT FERRAND
SIRET: 31124863700861 ouvert
1280 AV DES PLATANES FUTURE BUILDING 1
34970 LATTES
SIRET: 31124863700887 ouvert
3 B RUE DE L'OCTANT PARC D'ACTIVITE SUD GALAXIE
38130 ECHIROLLES
SIRET: 31124863700903 ouvert
53 RUE Berthy Albrecht (ZI COURTINE III)
84000 Avignon
SIRET: 31124863700945 ouvert
26 B RTE DE FOUGERES CHALET DE VAUX
35510 CESSON-SEVIGNE
SIRET: 31124863700960 ouvert
4 RUE DU WATTMAN LE CARDO
44700 ORVAULT
SIRET: 31124863700978 ouvert
6 AV MONTAIGNE
93160 NOISY-LE-GRAND
SIRET: 31124863700986 ouvert
ALL LAC DE TIGNES LE SIRIUS
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
SIRET: 31124863700994 ouvert
6 AV ALBERT ROUVIERE
81200 MAZAMET
SIRET: 31124863701000 ouvert
10 BD Lundy
51100 Reims
SIRET: 31124863701018 ouvert
RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS
31500 TOULOUSE
SIRET: 31124863701067 ouvert
5 RUE DE BERNE
67300 SCHILTIGHEIM
SIRET: 31124863701075 ouvert
5 ENTREE SERPENOISE CENTRE COMMERCIAL ST JACQUES
57000 METZ
SIRET: 31124863701091 ouvert
13 RUE CLAUDE CHAPPE
57070 METZ
SIRET: 31124863701109 ouvert
18 PL DU FORUM CENTRE SAINT JACQUES
57000 METZ
SIRET: 31124863701117 ouvert
14 RUE Jean Giono
21000 Dijon
SIRET: 31124863701133 ouvert
PORT DE PLAISANCE DOMAINE PUBLIC MARITIME PORNICHET
44380 PORNICHET
SIRET: 31124863701141 ouvert
10 RUE RAYMOND RALLIER DU BATY (ZAC DE KEROMAN)
56100 LORIENT
SIRET: 31124863701158 ouvert
19 BD JULES CARTERET 19-23-14 ESPACE HENRI VALLEE
69007 LYON 7E ARRONDISSEMENT
SIRET: 31124863701166 ouvert
40 RUE PAPIN
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
SIRET: 31124863701174 ouvert
RUE AMEDEE BARBOTTEAU ZAC HOUELBOURG SUD
97122 BAIE-MAHAULT
SIRET: 31124863701190 ouvert
13 QUAI GEORGE V
76600 LE HAVRE
SIRET: 31124863701216 ouvert
165 AV du prado
13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT
SIRET: 31124863701224 ouvert
138 BD de la Rochelle
55000 Bar-le-Duc
SIRET: 31124863701232 ouvert
171 RUE Newcastle
54000 Nancy
SIRET: 31124863701240 ouvert
1 RUE Rene Cassin
14280 Saint-Contest
SIRET: 31124863701257 ouvert
2 Mail de l'Europe Parc du Grand Troyes
10300 Sainte-Savine
SIRET: 31124863701034 fermé
Fermé le 05/11/2025
32 B RUE RAYMOND POINCARE
54000 NANCY
SIRET: 31124863701182 fermé
Fermé le 23/05/2025
1 RUE MARTIN LUTHER KING
14280 SAINT-CONTEST
SIRET: 31124863701059 fermé
Fermé le 06/01/2025
42 B RUE de la Paix
10000 Troyes
SIRET: 31124863701042 fermé
Fermé le 01/01/2025
5 RUE CHARLES KRUG
25000 BESANCON
SIRET: 31124863701026 fermé
Fermé le 31/12/2024
40 BD RAYMOND POINCARE 40-42
55000 BAR-LE-DUC
SIRET: 31124863700648 fermé
Fermé le 19/11/2024
480 AV DU PRADO
13008 MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT
SIRET: 31124863700804 fermé
Fermé le 04/03/2024
33 QUAI DE DION BOUTON 33-34
92800 PUTEAUX
SIRET: 31124863700408 fermé
Fermé le 23/10/2023
MORNE A ROCHE IMM. CONNEXION
97122 BAIE-MAHAULT
SIRET: 31124863700820 fermé
Fermé le 28/07/2023
11 PRV DE ROTTERDAM 180 TOUR LILLE EUROPE -
59777 LILLE
SIRET: 31124863700812 fermé
Fermé le 21/09/2022
26 RUE EMILE DECORPS
69100 VILLEURBANNE
SIRET: 31124863700853 fermé
Fermé le 06/09/2022
164 AV JEAN JAURES
69007 LYON
SIRET: 31124863701125 fermé
Fermé le 01/02/2022
RUE CLAUDE CHAPPE OXYGENE, BATIMENT A
35510 CESSON-SEVIGNE
SIRET: 31124863701083 fermé
Fermé le 21/11/2021
6 RUE GAMBETTA
57000 METZ
SIRET: 31124863700937 fermé
Fermé le 30/04/2021
RUE DU SOUS-MARIN VENUS
56100 LORIENT
SIRET: 31124863700234 fermé
Fermé le 01/10/2018
12 RUE DU CENTRE NUM VOIE 12 A 14
93160 NOISY-LE-GRAND
SIRET: 31124863700895 fermé
Fermé le 17/09/2018
28 PL GEORGES CLEMENCEAU
73100 AIX-LES-BAINS
SIRET: 31124863700929 fermé
Fermé le 29/06/2018
24 RUE DUHESME
75018 PARIS
SIRET: 31124863700911 fermé
Fermé le 01/03/2018
6 RUE DE LA TREMOILLE
75008 PARIS
SIRET: 31124863700952 fermé
Fermé le 01/03/2018
2 AV DES AMETHYSTES
44300 NANTES
SIRET: 31124863700879 fermé
Fermé le 30/11/2017
68 RUE CASSIOPEE
74650 CHAVANOD
SIRET: 31124863700846 fermé
Fermé le 02/11/2015
111 RTE DES REMOULEURS ZI COURTINE
84000 AVIGNON
SIRET: 31124863700457 fermé
Fermé le 11/11/2013
17 AV GEORGES POMPIDOU IMMEUBLE DANICA
69003 LYON
SIRET: 31124863700747 fermé
Fermé le 17/07/2013
48 RUE JACQUES DULUD
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
SIRET: 31124863700275 fermé
Fermé le 30/09/2012
27 AV DU 6 JUIN
14000 CAEN
SIRET: 31124863700549 fermé
Fermé le 30/09/2012
9 RUE DE LA RAVINELLE
54000 NANCY
SIRET: 31124863700580 fermé
Fermé le 30/09/2012
RUE DE JEMMAPES
44000 NANTES
SIRET: 31124863700614 fermé
Fermé le 30/09/2012
32 RUE DE LA JONQUIERE
75017 PARIS
SIRET: 31124863700689 fermé
Fermé le 30/09/2012
120 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
SIRET: 31124863700697 fermé
Fermé le 30/09/2012
2 AV FREDERIC ESTEBE
31200 TOULOUSE
SIRET: 31124863700705 fermé
Fermé le 30/09/2012
33 PL SEBASTOPOL
59000 LILLE
SIRET: 31124863700754 fermé
Fermé le 30/09/2012
11 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
SIRET: 31124863700770 fermé
Fermé le 30/09/2012
34 RUE JULES VERNE
44700 ORVAULT
SIRET: 31124863700010 fermé
Fermé le 07/05/2012
2 RUE ANCELLE 2 A 8
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
SIRET: 31124863700606 fermé
Fermé le 23/11/2009
246 BD GODARD
33300 BORDEAUX
SIRET: 31124863700598 fermé
Fermé le 30/06/2009
402 AV D'ARES
33700 MERIGNAC
SIRET: 31124863700481 fermé
Fermé le 31/12/2008
16 RUE JEAN LECANUET
76000 ROUEN
SIRET: 31124863700515 fermé
Fermé le 31/12/2008
31 BD MARECHAL FOCH IMMEUBLE LE GRILLON
38000 GRENOBLE
SIRET: 31124863700523 fermé
Fermé le 31/12/2008
13 RUE CAMILLE GODARD
33000 BORDEAUX
SIRET: 31124863700572 fermé
Fermé le 31/12/2008
15 AV DE PLANTIERES
57070 METZ
SIRET: 31124863700713 fermé
Fermé le 31/12/2008
8 B AV DE LA MARNE
59200 TOURCOING
SIRET: 31124863700721 fermé
Fermé le 29/04/2008
62 RUE JULES AUBER
97400 SAINT-DENIS
SIRET: 31124863700507 fermé
Fermé le 01/01/2008
47 BD DE CHANZY
93100 MONTREUIL
SIRET: 31124863700622 fermé
Fermé le 01/01/2008
15 RUE LAMORICIERE
44100 NANTES
SIRET: 31124863700655 fermé
Fermé le 01/01/2008
2 RUE CREBILLON
44000 NANTES
SIRET: 31124863700762 fermé
Fermé le 01/01/2008
14 RUE HUMBLOT
75015 PARIS
SIRET: 31124863700291 fermé
Fermé le 01/01/2006
10 BD VICTOR HUGO
34000 MONTPELLIER
SIRET: 31124863700366 fermé
Fermé le 01/01/2006
20 PL DES HALLES
67000 STRASBOURG
SIRET: 31124863700739 fermé
Fermé le 01/01/2006
GALLIAS QUARTIER DE COURTINE
84000 AVIGNON
SIRET: 31124863700564 fermé
Fermé le 30/12/2005
11 PRV DE ROTTERDAM 180 TOUR LILLEUROPE
59777 LILLE
SIRET: 31124863700101 fermé
Fermé le 30/09/2004
414 RUE DE PARIS
59500 DOUAI
SIRET: 31124863700465 fermé
Fermé le 01/07/2004
50 RUE MAZELLE
57000 METZ
SIRET: 31124863700499 fermé
Fermé le 31/12/2003
16 AV CHARLES DE GAULLE ESPACE ENTREPRISES
31130 BALMA
SIRET: 31124863700671 fermé
Fermé le 31/12/2003
11 RUE DU MAT DU PAVILLON
97400 SAINT-DENIS
SIRET: 31124863700093 fermé
Fermé le 30/09/2002
2 RUE DU PRIEZ
59800 LILLE
SIRET: 31124863700663 fermé
Fermé le 01/01/2002
27 PL DES CARMES
84000 AVIGNON
SIRET: 31124863700531 fermé
Fermé le 31/12/2001
15 RUE GRESSET
44000 NANTES
SIRET: 31124863700556 fermé
Fermé le 22/12/2001
3 RUE JEAN MONNET
94270 LE KREMLIN-BICETRE
SIRET: 31124863700119 fermé
Fermé le 31/12/2000
24 AV DU PRADO
13006 MARSEILLE
SIRET: 31124863700325 fermé
Fermé le 11/10/1999
51 RUE CAMILLE GODARD
33000 BORDEAUX
SIRET: 31124863700176 fermé
Fermé le 01/04/1999
10 RUE DE SERRE
54000 NANCY
SIRET: 31124863700416 fermé
Fermé le 01/01/1999
2 RUE DU CHATEAU DE L'ERAUDIERE LE NEBRASKA PORTE A 1ER ET
44300 NANTES
SIRET: 31124863700358 fermé
Fermé le 12/06/1997
36 PORT SAINT SAUVEUR
31000 TOULOUSE
SIRET: 31124863700432 fermé
Fermé le 01/02/1997
15 RUE ALFRED KASTLER PARC ACTIVITES LA VATINE
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
SIRET: 31124863700309 fermé
Fermé le 30/12/1996
2793 CHE DE SAINT CLAUDE CENTRE GALAXIE
06600 ANTIBES
SIRET: 31124863700317 fermé
Fermé le 25/12/1996
31 AV FOCH
57000 METZ
SIRET: 31124863700341 fermé
Fermé le 25/12/1994
140 RUE GARIBALDI 140-144
69003 LYON
SIRET: 31124863700424 fermé
Fermé le 01/04/1994
72 AV GEORGES CLEMENCEAU 72-78
92000 NANTERRE
SIRET: 31124863700150 fermé
Fermé le 25/12/1993
57 RUE SAINT MAUR
76000 ROUEN
SIRET: 31124863700226 fermé
Fermé le 25/12/1993
6 BD JEAN PAIN LE FORUM
38000 GRENOBLE
SIRET: 31124863700267 fermé
Fermé le 25/12/1993
8 RUE ANDRE MOINIER
63000 CLERMONT-FERRAND
SIRET: 31124863700382 fermé
Fermé le 19/04/1993
71 RUE VICTOR HUGO
97200 FORT-DE-FRANCE
SIRET: 31124863700374 fermé
Fermé le 08/10/1992
3 ALL DES TANNEURS
44000 NANTES

Dirigeants et représentants

3 Dirigeant(s) en exercice

PULLUM ANNE BRENNAN Président de SAS
DUSSUYER NICOLAS DIDIER JOHANNES Directeur Général
DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire
 SIREN: 572028041

Comptes annuels 9

Historique des dépôts de comptes annuels auprès du greffe

Appels d'offres remportés en 2026 41

Assurance dommages-ouvrage pour le Conservatoir...
Marché Services
Montant: 3 820,00€
Durée: 144 mois
Notification: 28/04/2026
Lieu d'exécution: 33260
Procédure: Procédure adaptée
LOT 7 DROITS STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 457 979,96€
Durée: 48 mois
Notification: 23/04/2026
Lieu d'exécution: 38603
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES
Marché Services
Acheteur: CA DE LA PROVENCE VERTE Groupement de communes
Montant: 1 266 230,18€
Durée: 60 mois
Notification: 21/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 3 FLOTTE AUTOMOBILE ASSURANCES DE LA VILLE
Marché Services
Montant: 78 392,00€
Durée: 48 mois
Notification: 17/04/2026
Lieu d'exécution: 97100
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCES POUR LES BESOINS CAB VILLE CCAS LOT...
Marché Services
Montant: 726 269,01€
Durée: 60 mois
Notification: 16/04/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRES DU SYNDICAT
Marché Services
Acheteur: SYNDICAT AZUR Syndicat mixte
Montant: 400 000,00€
Durée: 48 mois
Notification: 13/04/2026
Lieu d'exécution: 95100
Procédure: Appel d'offres ouvert
Prestations d’assurances - Risques statutaires...
Marché Services
Montant: 282 291,80€
Durée: 60 mois
Notification: 07/04/2026
Lieu d'exécution: 44150
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCE TOUS RISQUES OEUVRES D’ART
Marché Services
Montant: 419 000,00€
Durée: 60 mois
Notification: 31/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCES POUR LES BESOINS CAB VILLE CCAS LOT...
Marché Services
Acheteur: CA DU BEAUVAISIS Groupement de communes
Montant: 187 200,59€
Durée: 60 mois
Notification: 26/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
CONTRAT ASSURANCE TOUS RISQUES EXPOSITION
Marché Services
Acheteur: DEPARTEMENT DU VAR Département
Montant: 133 363,85€
Durée: 60 mois
Notification: 25/03/2026
Lieu d'exécution: 83076
Procédure: Procédure adaptée
Contrat d’assurances - Risques statutaires
Marché Services
Montant: 162 680,60€
Durée: 48 mois
Notification: 24/03/2026
Lieu d'exécution: 60200
Procédure: Appel d'offres ouvert
DROITS STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 285 214,54€
Durée: 48 mois
Notification: 23/03/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCES - Risque Statutaire
Marché Services
Montant: 132 176,75€
Durée: 60 mois
Notification: 13/03/2026
Lieu d'exécution: 83640
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCE - ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 834 267,15€
Durée: 72 mois
Notification: 11/03/2026
Lieu d'exécution: 33160
Procédure: Procédure adaptée
Prestations d’assurance Responsabilité Civile (...
Marché Services
Montant: 200 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 10/03/2026
Lieu d'exécution: 97212
Procédure: Procédure adaptée
DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES
Marché Services
Montant: 842 842,94€
Durée: 60 mois
Notification: 09/03/2026
Lieu d'exécution: 40006
Procédure: Appel d'offres ouvert
Assurances des risques statutaires ? Lot n°1
Marché Services
Montant: 305 247,45€
Durée: 48 mois
Notification: 05/03/2026
Lieu d'exécution: 44310
Procédure: Procédure adaptée
LOT 1 - MARCHE DE SERVICE D’ASSURANCES - ASSURA...
Marché Services
Montant: 794 297,58€
Durée: 59 mois
Notification: 04/03/2026
Lieu d'exécution: 01108
Procédure: Appel d'offres ouvert
PRESTATION DE SERVICE ASSURANCE PREVOYANCE STAT...
Marché Services
Montant: 419 417,15€
Durée: 60 mois
Notification: 04/03/2026
Lieu d'exécution: 77270
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 5 - RISQUES STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 514 202,53€
Durée: 48 mois
Notification: 27/02/2026
Lieu d'exécution: 45200
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 1 - Assurance Dommages aux biens
Marché Services
Montant: 178 143,72€
Durée: 48 mois
Notification: 26/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Lot 5 Risques statutaire des agents CNRACL et a...
Marché Services
Acheteur: CA DU CENTRE LITTORAL Groupement de communes
Montant: 237 442,30€
Durée: 60 mois
Notification: 25/02/2026
Lieu d'exécution: 97357
Procédure: Appel d'offres ouvert
MARCHE ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS LOT N° 2 DE...
Marché Services
Montant: 387 860,44€
Durée: 60 mois
Notification: 24/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
MARCHE DE SERVICE RELATIF AUX PRESTATIONS D ASS...
Marché Services
Acheteur: DEPARTEMENT DU DOUBS Département
Montant: 139 351,90€
Durée: 60 mois
Notification: 17/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 2 - MARCHE DE SERVICE D’ASSURANCES - RISQUE...
Marché Services
Montant: 1 355 609,50€
Durée: 60 mois
Notification: 17/02/2026
Lieu d'exécution: 01108
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 5 ASSURANCE MULTIRISQUES EXPOSITIONS
Marché Services
Acheteur: DEPARTEMENT DES VOSGES Département
Montant: 118 229,16€
Durée: 48 mois
Notification: 13/02/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCES GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE DE DUN...
Marché Services
Montant: 61 923,07€
Durée: 49 mois
Notification: 11/02/2026
Lieu d'exécution: 59183
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCES COMMUNALES - LOT 4 - ASSURANCES DES...
Marché Services
Montant: 926 304,85€
Durée: 48 mois
Notification: 06/02/2026
Lieu d'exécution: 13150
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 1 : DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES
Marché Services
Montant: 149 137,72€
Durée: 24 mois
Notification: 28/01/2026
Lieu d'exécution: 97470
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT 4 RISQUES STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 351 416,67€
Durée: 60 mois
Notification: 26/01/2026
Lieu d'exécution: 62160
Procédure: Appel d'offres ouvert
MARCHE ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS LOT N° 1 PR...
Marché Services
Montant: 5 923 234,19€
Durée: 60 mois
Notification: 24/01/2026
Lieu d'exécution:
Procédure: Appel d'offres ouvert
Assurance des prestations statutaires - Lot 6
Marché Services
Montant: 46 772,23€
Durée: 48 mois
Notification: 23/01/2026
Lieu d'exécution: 60290
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCE DES PRESTATIONS STATUTAIRES GRAS SAVOYE
Marché Services
Montant: 380 000,00€
Durée: 60 mois
Notification: 22/01/2026
Lieu d'exécution: 76240
Procédure: Appel d'offres ouvert
CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE
Marché Services
Montant: 1 012 046,56€
Durée: 48 mois
Notification: 21/01/2026
Lieu d'exécution: 91540
Procédure: Appel d'offres ouvert
PRESTATIONS D’ASSURANCE-FLOTTE AUTOMOBILE
Marché Services
Montant: 1 480 987,92€
Durée: 48 mois
Notification: 20/01/2026
Lieu d'exécution: 97200
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT8 ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES VILLE THEOUL...
Marché Services
Montant: 389 472,90€
Durée: 48 mois
Notification: 19/01/2026
Lieu d'exécution: 06590
Procédure: Appel d'offres ouvert
PRESTATIONS D ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES
Marché Services
Acheteur: CC NEBBIU - CONCA D'ORO Groupement de communes
Montant: 172 000,00€
Durée: 36 mois
Notification: 15/01/2026
Lieu d'exécution: 20217
Procédure: Procédure adaptée
LOT 05RISQUES STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 165 302,46€
Durée: 48 mois
Notification: 12/01/2026
Lieu d'exécution: 44730
Procédure: Procédure adaptée
Assurance " risques statutaires du personnel "...
Marché Services
Montant: 220 780,00€
Durée: 60 mois
Notification: 09/01/2026
Lieu d'exécution: 44330
Procédure: Appel d'offres ouvert
ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL
Marché Services
Montant: 220 780,30€
Durée: 60 mois
Notification: 09/01/2026
Lieu d'exécution: 44330
Procédure: Appel d'offres ouvert
LOT06 PRESTATIONS STATUTAIRES
Marché Services
Montant: 395 347,12€
Durée: 48 mois
Notification: 06/01/2026
Lieu d'exécution: 45240
Procédure: Appel d'offres ouvert

Annonces BODACC 20

Historique des publications au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales

BODACC C Dépôts des comptes
25/05/2025
N° 20250100-5510 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2024-12-31
BODACC A Ventes et cessions
11/09/2024
N° 20240176-2137 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION Willis Towers Watson France Société par actions simplifiée Au capital de : 1 432 600,00 EUR Siège social Tour Hekla 52 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux N° RCS 311 248 637 RCS Nanterre, est société absorbante SAGERIS Société à responsabilité limitée Au capital de : 7 622,45 EUR Siège social Tour Hekla 52 Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux N° RCS 413 856 055 RCS Nanterre, est société absorbée ACTIF : 216.906 € PASSIF : 60.132 € Actif net apporté : 156.774,33 € Le rapport d’échange de droits sociaux : NEANT – la société absorbante détenant l’intégralité des actions composant le capital de la société absorbée. Le montant prévu de la prime de fusion : NEANT Boni de fusion : 148.390,33 € Date du projet : 06/09/2024 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 06/09/2024, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société SAGERIS et au nom de la société Willis Towers Watson France
BODACC C Dépôts des comptes
26/05/2024
N° 20240100-5164 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2023-12-31
BODACC B Modifications diverses
21/04/2024
N° 20240079-2879 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : PULLUM Anne Brennan ; Directeur général : DUSSUYER Nicolas, Didier, Johannes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC B Modifications diverses
08/03/2024
N° 20240048-2177 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
transfert du siège social. - Président : PULLUM Anne Brennan ; Directeur général : TONDU-MELIQUE Florence ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC A Ventes et cessions
09/11/2023
N° 20230216-1293 Puteaux, Le Havre (92800, 76600) - Seine-Maritime
Greffe du Tribunal de Commerce du Havre
Avis initial
Adresse de l'ancien propriétaire : 13 Quai George V 76600 LE HAVRE. Adresse du nouveau propriétaire : 33-34 Quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX. Adresse de l'ancien propriétaire : 13 Quai George V 76600 LE HAVRE. - Début d'activité: 2023-11-02
BODACC A Ventes et cessions
13/09/2023
N° 20230176-1762 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION Willis Towers Watson France Société par actions simplifiée Au capital de : 1 432 600,00 EUR Siège social 33-34 Quai DE DION BOUTON 92800 Puteaux N° RCS 311 248 637 RCS Nanterre, est société absorbante Willis Towers Watson NSA Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 1 645 710,00 EUR Siège social 19/23 Boulevard Jules Carteret 14 Espace Henri Vallée 69007 Lyon 7e Arrondissement N° RCS 382 164 275 RCS Lyon, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 25.697.488,79 € Passif : 15.501.020,42 € Rapport d’échange des droits sociaux : néant Montant prévu de la prime de fusion : néant Date du projet : 06/09/2023 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 07/09/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société Willis Towers Watson France Date de dépôt : 07/09/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Lyon au nom de la société Willis Towers Watson NSA
BODACC A Ventes et cessions
13/09/2023
N° 20230176-1761 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION Willis Towers Watson France Société par actions simplifiée Au capital de : 1 432 600,00 EUR Siège social 33-34 Quai DE DION BOUTON 92800 Puteaux N° RCS 311 248 637 RCS Nanterre, est société absorbante Willis Towers Watson Dero Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 150 000,00 EUR Siège social 13 Quai George V 76600 Le Havre N° RCS 488 743 477 RCS Le Havre, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 6.597.716,08 € Passif : 3.232.999,43 € Rapport d’échange des droits sociaux : néant Montant prévu de la prime de fusion : néant Date du projet : 06/09/2023 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 07/09/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société Willis Towers Watson France Date de dépôt : 08/09/2023, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Le Havre au nom de la société Willis Towers Watson Dero
BODACC B Modifications diverses
06/06/2023
N° 20230107-3088 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : PULLUM Anne Brennan ; Directeur général : TONDU Florence ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC C Dépôts des comptes
06/06/2023
N° 20230107-5352 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2022-12-31
BODACC B Modifications diverses
14/08/2022
N° 20220157-2227 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : PULLUM Anne Brennan ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC B Modifications diverses
29/05/2022
N° 20220104-4057 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : PULLUM Anne Brennan ; Directeur général : de Montgolfier Cyrille ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
BODACC C Dépôts des comptes
20/05/2022
N° 20220099-8054 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2021-12-31
BODACC A Ventes et cessions
13/05/2022
N° 20220094-1407 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION Willis Towers Watson France Société par actions simplifiée Au capital de : 1 432 600,00 EUR Siège social 33-34 Quai DE DION BOUTON 92800 Puteaux N° RCS 311 248 637 RCS Nanterre, est société absorbante INFORMATIQUE ET ASSOCIES 3 Société par actions simplifiée Au capital de : 97 000,00 EUR Siège social 1 Place Paul Verlaine 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 507 901 171 RCS Nanterre, est société absorbée Actif : 535 939,00 EUR Passif : 489 186,00 EUR Actif net apporté : Rapport d'échange des droits sociaux : néant Montant prévu de la prime de fusion : néant Date du projet : 11/05/2022 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 11/05/2022, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société INFORMATIQUE ET ASSOCIES 3 et au nom de la société Willis Towers Watson France
BODACC B Modifications diverses
09/03/2022
N° 20220048-2121 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Avis initial
Modification survenue sur la dénomination.
BODACC A Ventes et cessions
14/11/2021
N° 20210221-2186 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
AVIS DE PROJET DE FUSION GRAS SAVOYE Société par actions simplifiée Au capital de : 1 432 600,00 EUR Siège social 33-34 Quai DE DION BOUTON 92800 Puteaux N° RCS 311 248 637 RCS Nanterre, est société absorbante AVENIR 2 Société par actions simplifiée Au capital de : 10,00 EUR Siège social 33-34 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux N° RCS 509 530 499 RCS Nanterre, est société absorbée Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 0 € Passif : 17 .810 € Rapport d’échange des droits sociaux : néant Montant prévu de la prime de fusion : néant Date du projet : 09/11/2021 Date et lieu de dépôt : Date de dépôt : 09/11/2021, lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Nanterre au nom de la société AVENIR 2 et au nom de la société GRAS SAVOYE
BODACC C Dépôts des comptes
12/08/2021
N° 20210156-11024 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
25/05/2021
N° 20210101-6628 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2020-12-31
BODACC C Dépôts des comptes
23/06/2020
N° 20200120-4830 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Comptes annuels et rapports - Clôture: 2019-12-31
BODACC B Modifications diverses
28/05/2020
N° 20200102-2361 Puteaux (92800) - Hauts-de-Seine
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Avis initial
Modification survenue sur l'administration. - Président : PULLUM Anne Brennan ; Directeur général : de Montgolfier Cyrille ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS